BUCHAN MARITIME LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBUCHAN MARITIME LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04374595
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BUCHAN MARITIME LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rugby Chambers 2
    Rugby Street
    WC1N 3QU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THRIFTCLOSE LIMITED15. Feb. 200215. Feb. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Juli 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Juli 2013

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Juli 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 20. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Juli 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Juli 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Juli 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Juli 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von BUCHAN MARITIME LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWNE, Valentine Martin Christopher Stephen
    5 Kings Avenue
    IG8 0JD Woodford Green
    Essex
    Sekretär
    5 Kings Avenue
    IG8 0JD Woodford Green
    Essex
    British7338990002
    BROWNE, Valentine Martin Christopher Stephen
    5 Kings Avenue
    IG8 0JD Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    5 Kings Avenue
    IG8 0JD Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish7338990002
    KENNEDY, Gary Alexander
    Cairnhill Croft
    Culsalmond
    AB52 6UT Insch
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Cairnhill Croft
    Culsalmond
    AB52 6UT Insch
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish84686020003
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Sekretär
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Other95892040003
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Sekretär
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    British95892040001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Sekretär
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOther95892040003
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Australian49828980005
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritish72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritish83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritish99475270002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    British72665990003

    Hat BUCHAN MARITIME LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A ship mortgage deed and collateral declaration of pledge
    Erstellt am 08. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel skandi buchan and in her various parts and appurtenances see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    A third priority deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 03. Juli 2008
    Geliefert am 15. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest present and future in and to the insurances of the vessel see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority norwegian ship mortgage over M.V. "skandi buchan"
    Erstellt am 17. Feb. 2003
    Geliefert am 03. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    An amount not exceeding £30M in respect of all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dof (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    First priority norwegian ship mortgage
    Erstellt am 17. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Gbp 75,000,000 due or to become due from allco finance (UK) limited ("allco (UK)") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The nis flag vessel M.V."skandi buchan" registered in the norwegian international ship register in the name of the company (having signal letters LAWP5) including all parts and appertenances whatsoever and all insurance sums thereon; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Second priority norwegian ship mortgage
    Erstellt am 17. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Gbp 75,000,000 due or to become due from allco finance (UK) limited ("allco (UK)") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The nis flag vessel M.V."skandi buchan" registered in the norwegian international ship register in the name of the company (having signal letters LAWP5) including all parts and appertenances whatsoever and all insurance sums thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Equipment Leasing (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority deed of assignment of insurances relating to "skandi buchan" (ex hull no.18)
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 19. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due from allco finance (UK) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in,to and under the insurancesv and all payments in respect of all claims,rights and remedies thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dof (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority bahamanian statutory ship mortgage over the M.V."skandi buchan"
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 19. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64THS shares in the vessel registered under the laws and flag of the commonwealth of the bahamas at the port of nassau,official no 8000539 and her boats,guns,ammunition,small arms and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Dof (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 16. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the bahamas registered ship "skandi buchan" with official no 8000539 and her boats,guns,ammunition etc.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Equipment Leasing (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys,liabilities and obligations due or to become due from any of the secured parties to the chargee or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in,to and under the insurances (as defined) in respect of the vessel "skandi buchan" including all payments to the company in respect thereof and all claims,rights and remedies arising therefrom; any requisition compensation,as defined,each account,as defined,and all sums of money standing to the credit of an account and all proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Norwegian account pledge
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The maximum amount of gbp 75,000,000 and all moneys,liabilities and obligations due or to become due from any of the secured parties to the chargee or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any and all sub-pledged rights of the company pursuant to the pledge and all right,title,interest and benefits in and under the charterer's assignment,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    A first priority bahamas ship mortgage
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares of the ship "skandi buchan",registered at port of nassau under official no 8000539 with her boats,guns,ammunition and small arms.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    A second priority deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 04. Sept. 2002
    Geliefert am 16. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in and to all policies and contracts of insurance and/or reinsurance in respect of the bahamas registered ship M.V."skandi buchan" with official number 8000539 and any compensation payable thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Equipment Leasing (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2002
    Geliefert am 09. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from any of the security parties to the chargee and the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge over all undertaking,property and assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0