SOT SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SOT SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04375004 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SOT SOLUTIONS LIMITED?
- (7470) /
- (7487) /
Wo befindet sich SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 St. Petersgate SK1 1EB Stockport Cheshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NAVITAS FACILITIES SERVICES LIMITED | 27. Juli 2009 | 27. Juli 2009 |
| NAVITAS HEMWAY LIMITED | 04. Dez. 2003 | 04. Dez. 2003 |
| NAVITAS HEMWAY MAINTENANCE & ENVIRONMENTAL LIMITED | 17. Jan. 2003 | 17. Jan. 2003 |
| HEMWAY MAINTENANCE & ENVIRONMENTAL LIMITED | 15. Feb. 2002 | 15. Feb. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2007 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Dawson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 12-14 Macon Court Crewe Cheshire CW1 6EA* am 06. Nov. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed navitas facilities services LIMITED\certificate issued on 29/07/09 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 6 Seiten | MAR | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 53 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SOT SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMSON, Yvonne | Sekretär | Dairylands Road Church Lawton ST7 3EU Stoke-On-Trent 34 Cheshire | British | 135044750001 | ||||||
| CARTER, Carolyn Susan Grace | Sekretär | 20 Lunedale Road DA2 6LN Dartford Kent | British | 92874300001 | ||||||
| HEMMINGS, Kirston | Sekretär | 14 Fairhaven Wychwood Park CW2 5GG Crewe Cheshire | British | 97271940001 | ||||||
| MICHAELS, Simon Harvey | Sekretär | 34 Hillview Road HA5 4PA Pinner Middlesex | British | 110286730001 | ||||||
| DMCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900006030001 | |||||||
| DAWSON, David | Geschäftsführer | The Steps Commonside Boundary ST10 2NU Cheadle Staffs | United Kingdom | British | 115703120001 | |||||
| HEMMINGS, Brian John | Geschäftsführer | 14 Fairhaven Wychwood Park Weston CW2 5GG Crewe Cheshire | British | 85444140002 | ||||||
| HEMMINGS, Kirston | Geschäftsführer | 14 Fairhaven Wychwood Park CW2 5GG Crewe Cheshire | British | 97271940001 | ||||||
| MADELEY, Andrew | Geschäftsführer | 1 Maybury Close Codsall WV8 1DL Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 112519230001 | |||||
| MCFARLAND, Anthony | Geschäftsführer | Kigston Lodge Hays Navan County Meath Eire | Irish | 87207980002 | ||||||
| STANTON, David Andrew | Geschäftsführer | 19 Harebell Close WV10 7SY Wolverhampton West Midlands | British | 79642100001 | ||||||
| WILLIAMS, David John | Geschäftsführer | 3 Queens Square RH19 4PP West Hoathly West Sussex | England | British | 92874490001 | |||||
| DMCS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900004430001 |
Hat SOT SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Sept. 2007 Geliefert am 14. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Apr. 2007 Geliefert am 27. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 28. Okt. 2005 Geliefert am 29. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Okt. 2005 Geliefert am 26. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Okt. 2003 Geliefert am 23. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Okt. 2003 Geliefert am 23. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge all present and future stocks, shares and other securities and all ruights and interests accruing or offered in relation to them floating charge the whole of the property (including uncalled capital) and undertaking. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture relating to the paradene loan facility agreements | Erstellt am 07. Okt. 2003 Geliefert am 20. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all present and future stocks shares and other securities and all rights and interests accruing or offered at any time in relation to them and by way of floating charge all the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SOT SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0