GRACE FILMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GRACE FILMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04375471 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRACE FILMS LIMITED?
- Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation
- Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich GRACE FILMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRACE FILMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRACE FILMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Carmel Michelle Burke als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Carmel Michelle Burke als Direktor am 23. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Garner Freeston als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Peter Langenberg als Direktor am 01. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roderick Waldemar Lisle Henwood als Geschäftsführer am 01. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Julian Garner Freeston am 29. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Roderick Waldemar Lisle Henwood als Direktor am 01. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marc-Antoine D'halluin als Geschäftsführer am 01. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tim David Breadin als Geschäftsführer am 23. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRACE FILMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBOUR, Hamish Macvinish | Geschäftsführer | 14a Hatfield Drive G12 0YA Glasgow | Scotland | British | Creative Director | 35392400001 | ||||
BURKE, Carmel Michelle | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | Irish | Director | 224677940001 | ||||
GREGSON, Sarah Jane | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | British | Director | 29602640002 | ||||
LANGENBERG, Peter | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | United Kingdom | Dutch | Director | 222055210001 | ||||
CLEMENTS, Alan | Sekretär | 4 Cleveden Crescent G12 0PD Glasgow | British | Producer | 39073520002 | |||||
FREESTON, Julian Garner | Sekretär | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | 153183260001 | |||||||
MORRIS, Jillian Margaret | Sekretär | 65a Gardner Street G11 5BZ Glasgow Scotland | British | Company Secretary | 51288960001 | |||||
SLOW, Jonathan Mark | Sekretär | Brussels Road SW1 1UK London 8 | British | 138550940001 | ||||||
SMITH, David William | Sekretär | 15 Caiystane Terrace EH10 6SR Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 106115680001 | |||||
TM COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 | |||||||
BREADIN, Tim David | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 177047460001 | ||||
CLEMENTS, Alan | Geschäftsführer | 4 Cleveden Crescent G12 0PD Glasgow | United Kingdom | British | Producer | 39073520002 | ||||
D'HALLUIN, Marc-Antoine | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | French | Director | 172359320001 | ||||
FETHER, Joely Bryn | Geschäftsführer | Archibald Road N7 0AN London 27 England | England | British | Director | 42885320005 | ||||
FRANK, David Vincent Mutrie | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 152744230001 | ||||
FRANK, David Vincent Mutrie | Geschäftsführer | Ruvigny Gardens SW15 1JR London 9 United Kingdom | England | British | Director | 152744230001 | ||||
FREESTON, Julian Garner | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 153176720001 | ||||
FREESTON, Julian Garner | Geschäftsführer | Robin Hill Drive BR7 5ER Chislehurst 7 Kent England | England | British | Director | 153176720001 | ||||
HENWOOD, Roderick Waldemar Lisle | Geschäftsführer | The Gloucester Building Kensington Village W14 8RF Avonmore Road London | England | British | Director | 191508930001 | ||||
ORIEL, Susan Margaret Julie | Geschäftsführer | 21 Clancarty Road SW6 3AH London | Uk | British | Company Director | 125403860001 | ||||
PRICE, Janice Lynne | Geschäftsführer | 45 Southdean Gardens SW19 6NT London | British | Finance Director | 55643820003 | |||||
QUINN, Eileen | Geschäftsführer | 19 Oakhill Place Oakhill Road SW15 2QN Putney London | American | Producer | 33130440002 | |||||
ROGERS, Mark Ian James | Geschäftsführer | Kew Road TW9 3EB Richmond 36 Christopher Court Surrey England | United Kingdom | British | Lawyer | 93338140001 | ||||
SLOW, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Brussels Road SW11 2AF London 8 | United Kingdom | British | Director | 108443110002 | ||||
REYNARD NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 40850920001 | |||||||
TM COMPANY SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRACE FILMS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monogram Productions Limited | 06. Apr. 2016 | Kensington Village Avonmore Road W14 8RF London Gloucester Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GRACE FILMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge and security assignment | Erstellt am 16. Okt. 2008 Geliefert am 21. Okt. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all preprint elements, positive prints, soundtrack elements, literary property, copyright, music and musical compositions, contracts, sequels see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge (with effect as of 6 december 2002) over the programme provisionally entitled "saving grace" | Erstellt am 13. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest in and to the rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit and account | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge on deposits | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 18. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of gbp 1,734,234.22 deposited by the company in account number 4.01.39.220 gbp. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Juni 2002 Geliefert am 26. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 28. Mai 2002 Geliefert am 08. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bentley productions limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment the borrower's right, title and interest in and to the rights, the itv contract, the benefit of the insurance policies. By way of fixed charge the borrower's right, title and interest in and to the programme, the proceeds of the insurance policies and all sums in the borrowers current account. By way of floating charge any and all of the borrower's rights in and to the above to the extent they fail to operate as a fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0