GRACE FILMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRACE FILMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04375471
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRACE FILMS LIMITED?

    • Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation
    • Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich GRACE FILMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRACE FILMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRACE FILMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    11 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Carmel Michelle Burke als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Carmel Michelle Burke als Direktor am 23. Jan. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Julian Garner Freeston als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Peter Langenberg als Direktor am 01. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Roderick Waldemar Lisle Henwood als Geschäftsführer am 01. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    14 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Julian Garner Freeston am 29. Juli 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. März 2015

    Kapitalaufstellung am 13. März 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Roderick Waldemar Lisle Henwood als Direktor am 01. Sept. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Marc-Antoine D'halluin als Geschäftsführer am 01. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Tim David Breadin als Geschäftsführer am 23. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GRACE FILMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARBOUR, Hamish Macvinish
    14a Hatfield Drive
    G12 0YA Glasgow
    Geschäftsführer
    14a Hatfield Drive
    G12 0YA Glasgow
    ScotlandBritishCreative Director35392400001
    BURKE, Carmel Michelle
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    United KingdomIrishDirector224677940001
    GREGSON, Sarah Jane
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    United KingdomBritishDirector29602640002
    LANGENBERG, Peter
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    United KingdomDutchDirector222055210001
    CLEMENTS, Alan
    4 Cleveden Crescent
    G12 0PD Glasgow
    Sekretär
    4 Cleveden Crescent
    G12 0PD Glasgow
    BritishProducer39073520002
    FREESTON, Julian Garner
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Sekretär
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    153183260001
    MORRIS, Jillian Margaret
    65a Gardner Street
    G11 5BZ Glasgow
    Scotland
    Sekretär
    65a Gardner Street
    G11 5BZ Glasgow
    Scotland
    BritishCompany Secretary51288960001
    SLOW, Jonathan Mark
    Brussels Road
    SW1 1UK London
    8
    Sekretär
    Brussels Road
    SW1 1UK London
    8
    British138550940001
    SMITH, David William
    15 Caiystane Terrace
    EH10 6SR Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    15 Caiystane Terrace
    EH10 6SR Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor106115680001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    37914570001
    BREADIN, Tim David
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    EnglandBritishDirector177047460001
    CLEMENTS, Alan
    4 Cleveden Crescent
    G12 0PD Glasgow
    Geschäftsführer
    4 Cleveden Crescent
    G12 0PD Glasgow
    United KingdomBritishProducer39073520002
    D'HALLUIN, Marc-Antoine
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    EnglandFrenchDirector172359320001
    FETHER, Joely Bryn
    Archibald Road
    N7 0AN London
    27
    England
    Geschäftsführer
    Archibald Road
    N7 0AN London
    27
    England
    EnglandBritishDirector42885320005
    FRANK, David Vincent Mutrie
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    EnglandBritishDirector152744230001
    FRANK, David Vincent Mutrie
    Ruvigny Gardens
    SW15 1JR London
    9
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ruvigny Gardens
    SW15 1JR London
    9
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector152744230001
    FREESTON, Julian Garner
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    EnglandBritishDirector153176720001
    FREESTON, Julian Garner
    Robin Hill Drive
    BR7 5ER Chislehurst
    7
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Robin Hill Drive
    BR7 5ER Chislehurst
    7
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector153176720001
    HENWOOD, Roderick Waldemar Lisle
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    Geschäftsführer
    The Gloucester Building
    Kensington Village
    W14 8RF Avonmore Road
    London
    EnglandBritishDirector191508930001
    ORIEL, Susan Margaret Julie
    21 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    Geschäftsführer
    21 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    UkBritishCompany Director125403860001
    PRICE, Janice Lynne
    45 Southdean Gardens
    SW19 6NT London
    Geschäftsführer
    45 Southdean Gardens
    SW19 6NT London
    BritishFinance Director55643820003
    QUINN, Eileen
    19 Oakhill Place
    Oakhill Road
    SW15 2QN Putney
    London
    Geschäftsführer
    19 Oakhill Place
    Oakhill Road
    SW15 2QN Putney
    London
    AmericanProducer33130440002
    ROGERS, Mark Ian James
    Kew Road
    TW9 3EB Richmond
    36 Christopher Court
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    Kew Road
    TW9 3EB Richmond
    36 Christopher Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritishLawyer93338140001
    SLOW, Jonathan Mark
    Brussels Road
    SW11 2AF London
    8
    Geschäftsführer
    Brussels Road
    SW11 2AF London
    8
    United KingdomBritishDirector108443110002
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    40850920001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    37914570001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRACE FILMS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8RF London
    Gloucester Building
    England
    06. Apr. 2016
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8RF London
    Gloucester Building
    England
    Nein
    RechtsformLimited Liability Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUk Companies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03328806
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat GRACE FILMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge and security assignment
    Erstellt am 16. Okt. 2008
    Geliefert am 21. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all preprint elements, positive prints, soundtrack elements, literary property, copyright, music and musical compositions, contracts, sequels see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fireman's Fund Insurance Company and International Film Guarantors Llc
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge (with effect as of 6 december 2002) over the programme provisionally entitled "saving grace"
    Erstellt am 13. Dez. 2002
    Geliefert am 19. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over cash deposit and account
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 19. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge on deposits
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 18. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of gbp 1,734,234.22 deposited by the company in account number 4.01.39.220 gbp. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Juni 2002
    Geliefert am 26. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 28. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 28. Mai 2002
    Geliefert am 08. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bentley productions limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the borrower's right, title and interest in and to the rights, the itv contract, the benefit of the insurance policies. By way of fixed charge the borrower's right, title and interest in and to the programme, the proceeds of the insurance policies and all sums in the borrowers current account. By way of floating charge any and all of the borrower's rights in and to the above to the extent they fail to operate as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0