ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04376722 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 10 Upper Berkeley Street London W1H 7PE |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Ross Collins am 17. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Neil Steinberg am 17. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Neil Steinberg am 17. Aug. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 043767220009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 043767220009 | 24 Seiten | MR01 | ||||||||||
Änderung der Belastung 8 | 15 Seiten | MR07 | ||||||||||
Änderung der Belastung 7 | 15 Seiten | MR07 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEINBERG, Mark Neil | Sekretär | 25 Cadogan Square SW1X 0HU London Flat 2 United Kingdom | British | Company Director | 59275730001 | |||||
COLE, Terence Shelby | Geschäftsführer | Phillimore Gardens W8 7QE London 24 | United Kingdom | British | Company Director | 71810060003 | ||||
COLLINS, Steven Ross | Geschäftsführer | W1U 2JH London 17 Bulstrode Street United Kingdom | England | British | Company Director | 7128850005 | ||||
STEINBERG, Mark Neil | Geschäftsführer | 25 Cadogan Square SW1X 0HU London Flat 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 59275730022 | ||||
CGNU COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | St. Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390003 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | Chartered Surveyor | 76584200002 | ||||
LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr | Geschäftsführer | High House Ranworth Road Hemblington NR13 4PJ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 62939740001 | ||||
MANSLEY, Nicholas John Fermor | Geschäftsführer | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | Economist | 73817060002 | ||||
WISE, David Andrew John | Geschäftsführer | 20 Parkway Southgate N14 6QU London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 74016310001 | ||||
WOMACK, Ian Bryan | Geschäftsführer | Fetherston House Walnut Hill Surlingham NR14 7DQ Norwich Norfolk | British | Insurance Company Official | 33902000001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.G.I.S. St Paul's House Limited | 06. Apr. 2016 | W1H 7PE London 10 Upper Berkeley Street United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ST PAUL'S HOUSE LEEDS NOMINEE NO 2 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 06. Sept. 2013 Geliefert am 20. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 01. Juli 2010 Geliefert am 12. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties (or any of them) or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge all its undertaking and all property assets and rights. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 05. Juli 2005 Geliefert am 22. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights both present and future. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fifty-fifth supplemental trust deed | Erstellt am 05. Juli 2005 Geliefert am 12. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by hemingway debenture limited to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the new property being f/h land k/a plot 5300 being part of land at tewkesbury business park northway lane tewkesbury t/n GR248788. F/h land being la fitness (also k/a north birmingham squash rackets club) 366 gravelly lane erdington birmingham t/n's WM108627 WN682318 WM232394 WM629635 and WM744301. L/h land at mill street brierley hill west midlands t/n WM775455. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Mai 2005 Geliefert am 06. Mai 2005 | Vollständig erf üllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land known as st paul's house st paul's street leeds and car park little queen street t/n's WYK71561 and WYK258186, fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deeds of accession to a subordination deed dated 24 december 2002 pursuant to which the company will become an obligor and subordinated creditor under the subordination deed and | Erstellt am 20. März 2003 Geliefert am 02. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by an obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future liabilities and obligations payable or owing by an obligor to any subordinated creditor, assign or puport to assign to any person the whole or any part of the subordinated liabilities, purport to set off at any time any amount, attempt to obtain repayment or prepayment of principal or payment of any interest, fees or commissions on, or by reference to, any of the subordinated liabilities otherwise than in accordance with the terms of the deed;. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. März 2003 Geliefert am 02. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any other chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Twentieth supplemental trust deed | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 02. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold property known as st paul's house st paul's street leeds t/no: WYK71561 and the freehold property being land on the east side of little queen street leeds t/no: WYK258186 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery, all improvements and additions thereto, with the benefit of all the existing leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 02. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and to the lenders (or any of them) or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all its undertaking property assets and rights both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0