CP (OASIS PROPERTY) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CP (OASIS PROPERTY) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04379582 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Edison Rise, New Ollerton Newark NG22 9DP Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALNERY NO. 2257 LIMITED | 22. Feb. 2002 | 22. Feb. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 20. Apr. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Zachary Bryan Vaughan als Geschäftsführer am 09. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin O'donnell Mccrain als Geschäftsführer am 12. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Natalie Johanna Adomait als Geschäftsführer am 09. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Inglett als Geschäftsführer am 04. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Grant Mckinlay am 03. Juli 2017 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Grant Mckinlay als Direktor am 03. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 20. Apr. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Zachary Bryan Vaughan am 28. Apr. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Natalie Johanna Adomait als Direktor am 25. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vikram Aneja als Geschäftsführer am 25. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 21. Apr. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 18 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGH-DEHAL, Rajbinder | Sekretär | Knighton Rise LE2 2RE Oadby 6 Leicestershire United Kingdom | Other | 138962680001 | ||||||
| DALBY, Martin Peter | Geschäftsführer | The Old Granary, Went Farm Main Street, Womersley DN6 9BQ Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 83381250004 | |||||
| MCKINLAY, Colin Grant | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 156396250002 | |||||
| BRADSHAW, Andrew Philip | Sekretär | The Chapel House Haseley Road OX44 7PP Little Milton Oxfordshire | British | 114356940001 | ||||||
| CUMMINS, Diarmuid | Sekretär | Westfieldbury Westland Green SG11 2AL Little Hadham Hertfordshire | British | 78791890003 | ||||||
| FRANCE, Malcolm Ronald | Sekretär | 34 Tybenham Road SW19 3LA London | British | 50060390001 | ||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Sekretär | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
| PARKER, Timothy Hugh | Sekretär | Kirton Road Egmanton NG2 0HF Newark Twitchell Barn Nottinghamshire | British | 138694570001 | ||||||
| STOLL, Peter Huston | Sekretär | Flat 5 20 Earls Court Square SW5 9DN London | United States | 107030970001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ADOMAIT, Natalie Johanna | Geschäftsführer | 99 Bishopsgate EC2M 3XD London Level 2 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 221376510001 | |||||
| ANEJA, Vikram | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Notts United Kingdom | England | Canadian | 205778000001 | |||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | One Edison Rise New Ollerton NG22 9DP Newark Nottinghamshire | Other | 94259330004 | ||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | One Edison Rise New Ollerton NG22 9DP Newark Nottinghamshire | Other | 94259330004 | ||||||
| BURYCH, Andrew | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 199966440001 | |||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Geschäftsführer | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| CUMMINS, Diarmuid | Geschäftsführer | Westfieldbury Westland Green SG11 2AL Little Hadham Hertfordshire | England | British | 78791890003 | |||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Geschäftsführer | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| FRANCE, Malcolm Ronald | Geschäftsführer | 34 Tybenham Road SW19 3LA London | United Kingdom | British | 50060390001 | |||||
| HAWKES, Edward Jonathan Cameron | Geschäftsführer | 143 Taybridge Street SW11 5PY London | United Kingdom | British | 93239900002 | |||||
| INGLETT, Paul | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81617110003 | |||||
| JONAS, Marc Nicholas | Geschäftsführer | Flat 2 89 Holland Park W11 3RZ London | England | British | 55841850004 | |||||
| MAWJI-KARIM, Farhad | Geschäftsführer | Pembridge Square W2 4EW London 3 England England | United Kingdom | British | 166000930001 | |||||
| MCCRAIN, Kevin O'Donnell | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | American | 195429180002 | |||||
| MCINTOSH, William Alan | Geschäftsführer | 7 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 46361590002 | ||||||
| MOY, Neal St John | Geschäftsführer | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||
| PARK, Alan | Geschäftsführer | 48 Langford Gardens Manthorpe Road NG31 8DW Grantham Lincolnshire | England | British | 117751510001 | |||||
| PIKE, Chad Rustan | Geschäftsführer | 25 Burnsall Street SW3 3SR London | United Kingdom | British | 87606860002 | |||||
| PIKE, Chad Rustan | Geschäftsführer | 25 Burnsall Street SW3 3SR London | United Kingdom | British | 87606860002 | |||||
| PURSLOW, Christian Mark Cecil | Geschäftsführer | The Grove Warren Park Coombe Hill KT2 7HX Kingston Upon Thames | United Kingdom | British | 83244210001 | |||||
| RUSTON, Christopher | Geschäftsführer | Fairfax Close Garstang PR3 1RU Preston 4 Lancashire | British | 117751550001 | ||||||
| SKAAR, Steven Jerry | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire United Kingdom | England | British | 195429190001 | |||||
| SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord | Geschäftsführer | 1 Shepherds Place Upper Brook Street W1K 6ED London | England | British | 54889660001 | |||||
| STOLL, Peter Huston | Geschäftsführer | Flat 5 20 Earls Court Square SW5 9DN London | United States | 107030970001 | ||||||
| VALERI, Andrea | Geschäftsführer | 57 Cumberland Mansions Seymour Place W1H 5TF London | England | Italian | 111379810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Cp Newmidco Limited | 06. Apr. 2016 | One Edison Rise New Ollerton NG22 9DP Newark United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CP (OASIS PROPERTY) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Borrower deed of charge | Erstellt am 28. Feb. 2012 Geliefert am 20. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Securitisation floating charge debenture | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intercreditor deed | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 05. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intercreditor deed | Erstellt am 14. Dez. 2006 Geliefert am 28. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at whinfell forest, brougham t/no CU116564 the l/h property k/a whinfell farm, brougham, t/no CU116467 and the l/h property k/a 1 and 2 sawmill cottages t/no CU129403 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Mai 2006 Geliefert am 23. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CP (OASIS PROPERTY) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0