CP (OASIS PROPERTY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCP (OASIS PROPERTY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04379582
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALNERY NO. 2257 LIMITED22. Feb. 200222. Feb. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis20. Apr. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 SeitenLIQ13

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Apr. 2018

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Zachary Bryan Vaughan als Geschäftsführer am 09. März 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin O'donnell Mccrain als Geschäftsführer am 12. März 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Natalie Johanna Adomait als Geschäftsführer am 09. März 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Feb. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Paul Inglett als Geschäftsführer am 04. Aug. 2017

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Grant Mckinlay am 03. Juli 2017

    3 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Colin Grant Mckinlay als Direktor am 03. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 20. Apr. 2017

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Zachary Bryan Vaughan am 28. Apr. 2017

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Natalie Johanna Adomait als Direktor am 25. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Vikram Aneja als Geschäftsführer am 25. Nov. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 21. Apr. 2016

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    18 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. März 2016

    Kapitalaufstellung am 29. März 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish83381250004
    MCKINLAY, Colin Grant
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156396250002
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Sekretär
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    Sekretär
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    British78791890003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Sekretär
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Sekretär
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Sekretär
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ADOMAIT, Natalie Johanna
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    Level 2
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    Level 2
    United Kingdom
    United KingdomCanadian221376510001
    ANEJA, Vikram
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    EnglandCanadian205778000001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    BURYCH, Andrew
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian199966440001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Geschäftsführer
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritish78791890003
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Geschäftsführer
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Geschäftsführer
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    Geschäftsführer
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritish93239900002
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81617110003
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    MAWJI-KARIM, Farhad
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    Geschäftsführer
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    United KingdomBritish166000930001
    MCCRAIN, Kevin O'Donnell
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomAmerican195429180002
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Geschäftsführer
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    PARK, Alan
    48 Langford Gardens
    Manthorpe Road
    NG31 8DW Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    48 Langford Gardens
    Manthorpe Road
    NG31 8DW Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritish117751510001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Geschäftsführer
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Geschäftsführer
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Geschäftsführer
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    RUSTON, Christopher
    Fairfax Close
    Garstang
    PR3 1RU Preston
    4
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Fairfax Close
    Garstang
    PR3 1RU Preston
    4
    Lancashire
    British117751550001
    SKAAR, Steven Jerry
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish195429190001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Geschäftsführer
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Geschäftsführer
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    VALERI, Andrea
    57 Cumberland Mansions
    Seymour Place
    W1H 5TF London
    Geschäftsführer
    57 Cumberland Mansions
    Seymour Place
    W1H 5TF London
    EnglandItalian111379810001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CP (OASIS PROPERTY) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05456337
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CP (OASIS PROPERTY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Borrower deed of charge
    Erstellt am 28. Feb. 2012
    Geliefert am 20. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Erstellt am 19. Juni 2007
    Geliefert am 04. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Intercreditor deed
    Erstellt am 19. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Intercreditor deed
    Erstellt am 14. Dez. 2006
    Geliefert am 28. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at whinfell forest, brougham t/no CU116564 the l/h property k/a whinfell farm, brougham, t/no CU116467 and the l/h property k/a 1 and 2 sawmill cottages t/no CU129403 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited as Trustee for Each of the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Mai 2006
    Geliefert am 23. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 23. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Juni 2005
    Geliefert am 24. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 24. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Nov. 2002
    Geliefert am 15. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CP (OASIS PROPERTY) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Apr. 2018Beginn der Liquidation
    30. Juli 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0