ASTRAEUS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASTRAEUS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04380108
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASTRAEUS LIMITED?

    • (6210) /
    • (6220) /
    • (7487) /

    Wo befindet sich ASTRAEUS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ZOLFO COOPER
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASTRAEUS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLAKEDEW 360 LIMITED22. Feb. 200222. Feb. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASTRAEUS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ASTRAEUS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASTRAEUS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2014

    14 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Mai 2013

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Okt. 2012

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Mai 2012

    14 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    43 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    41 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Astraeus House Faraday Court Crawley West Sussex RH10 9PU* am 25. Nov. 2011

    2 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    23 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mario Fulgoni als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Feb. 2011

    Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2011

    • Kapital: GBP 18,550,204.3
    SH01

    legacy

    8 SeitenMG01

    Ernennung von Skarphedinn Berg Steinarsson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Petur Halldorsson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    23 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    legacy

    10 SeitenMG01

    legacy

    10 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    46 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von ASTRAEUS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    Sekretär
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    British83058420001
    HARALDSSON, Palmi
    Solvallagata 7
    FOREIGN Reykjavik 101
    Iceland
    Geschäftsführer
    Solvallagata 7
    FOREIGN Reykjavik 101
    Iceland
    IcelandIcelandic98086060001
    STEINARSSON, Skarphedinn Berg
    Faraday Court
    RH10 9PU Crawley
    Astraeus House Unit D
    West Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Faraday Court
    RH10 9PU Crawley
    Astraeus House Unit D
    West Sussex
    United Kingdom
    IcelandIcelandic155055720001
    MANNING, Marcus Philip
    67 Redhill Drive
    BN1 5FL Brighton
    East Sussex
    Sekretär
    67 Redhill Drive
    BN1 5FL Brighton
    East Sussex
    British59036130005
    PARRY, Hugh Archibald Pryce
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    Sekretär
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    British6992430001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    BURGESS, Bradley William
    Tannery Close
    Slinfold
    RH13 0RW Horsham
    1
    West Sussex
    Uk
    Geschäftsführer
    Tannery Close
    Slinfold
    RH13 0RW Horsham
    1
    West Sussex
    Uk
    EnglandBritish80290780002
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    Geschäftsführer
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    EnglandBritish83058420001
    FULGONI, Mario Anthony James
    New Holme
    20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    New Holme
    20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77022760002
    FULGONI, Mario Anthony James
    New Holme
    20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    New Holme
    20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77022760002
    GEIRSSON, Kristinn Thor
    Mannalind 4
    Kopavogur
    201
    Iceland
    Geschäftsführer
    Mannalind 4
    Kopavogur
    201
    Iceland
    Icelandic122344400001
    GUDMUNDSSON, Thorsteinn Orn
    Asparhvarf 14
    Kopavogur
    203
    Iceland
    Geschäftsführer
    Asparhvarf 14
    Kopavogur
    203
    Iceland
    Icelandic122344560001
    HALLDORSSON, Petur Mar
    Graenamyri 1
    Seltjarnarnes
    170
    Iceland
    Geschäftsführer
    Graenamyri 1
    Seltjarnarnes
    170
    Iceland
    IcelandIcelandic114179430001
    HINKLES, Jonathan Paul
    Bridge Cottage
    1 Redehall Road
    RH6 9PX Smallfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bridge Cottage
    1 Redehall Road
    RH6 9PX Smallfield
    Surrey
    EnglandBritish74315550003
    HODGKISS, Stephen John
    Creevagh Cottage Forest Road
    RH18 5NA Forest Row
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Creevagh Cottage Forest Road
    RH18 5NA Forest Row
    East Sussex
    United KingdomBritish26719700001
    IMSLAND, Matthias
    Wambasel 39
    FOREIGN Rexnjavin
    Iceland 109
    Iceland
    Geschäftsführer
    Wambasel 39
    FOREIGN Rexnjavin
    Iceland 109
    Iceland
    Icelandic120544110001
    KRISTINSSON, Johannes
    Tue Bel Air
    5488 Ehnen
    7
    Luxembourg
    Geschäftsführer
    Tue Bel Air
    5488 Ehnen
    7
    Luxembourg
    Icelander129176510001
    MACFADYEN, Neil
    39 Lancaster Road
    W11 1QJ London
    Geschäftsführer
    39 Lancaster Road
    W11 1QJ London
    United KingdomBritish74569730002
    MAHON, Michael James
    81 Grovehill Road
    RH1 6DB Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    81 Grovehill Road
    RH1 6DB Redhill
    Surrey
    Ireland80096030002
    MANNING, Marcus Philip
    67 Redhill Drive
    BN1 5FL Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    67 Redhill Drive
    BN1 5FL Brighton
    East Sussex
    British59036130005
    PARRY, Hugh Archibald Pryce
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    EnglandBritish6992430001
    REEVES, William Thomas
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    British93316550001
    RUSHTON, Philip Steven Garnett
    6 Drayton Close
    KT22 9EZ Fetcham
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Drayton Close
    KT22 9EZ Fetcham
    Surrey
    EnglandBritish90286700001
    SMITH, Kenneth William
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    Geschäftsführer
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    British87819940001
    SORLI KRISTMUNDSSON, Olafur
    105 Reykjavik
    Hateigsvegur 12
    Iceland
    Geschäftsführer
    105 Reykjavik
    Hateigsvegur 12
    Iceland
    Icelandic128579970001
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001980001

    Hat ASTRAEUS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Lessee security agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 11. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tes Parts Limited
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of assignment of insurances
    Erstellt am 12. Aug. 2010
    Geliefert am 26. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rights title benefits and interest in and to all proceeds of the insurances and any and all requisition compensation in respect of one airbus A320-211 aircraft bearing serial number 0136 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aircraft Solutions Lux Iv S.A.R.L (The Assignee)
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Lessee security agreement
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 16. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral meaning the relevant insurance property and the relevant requisition compensation property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tes Parts Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Lease security agreement
    Erstellt am 19. Juni 2010
    Geliefert am 25. Juni 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee and by way of first priority security it is the full legal and beneficial owner of all right, title and interest in and to the collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tes Parts Limited (The "Assignee")
    Transaktionen
    • 25. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Lessee deed of assignment
    Erstellt am 01. Apr. 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company assigns to the assignee all its interest both present anfd future in the assigned property as continuing security to discharge the secured obligations. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Msn 28007 Leasing B.V.
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Travel Holding Hf
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 29. Nov. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Awms I
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment
    Erstellt am 29. Nov. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Awms I
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over deposit
    Erstellt am 25. Aug. 2006
    Geliefert am 05. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee and as continuing security for the payment or discharge of the secured liabilities hereby charges to the mortgagee by way of first fixed charge its entire right, title and interest in and to the deposit and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Sept. 2005
    Geliefert am 22. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit in the sum of £2,875.00.
    Berechtigte Personen
    • Mkt Properties Limited
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 06. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 06. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All its right, title, interest and benefit from time to time in and to the flight simulator and the documents, the benefits of all contracts and agreements, the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 05. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation rbsast usda with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 21914986 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Afm Nominees Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Johnstone Private Acquisitions Partnership Ii 'C'
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Johnstone Private Acquisitions Partnership Ii 'B'
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Vct 4 PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Vct 3 PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Johnstone Private Acquisitions Partnership Ii 'A'
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Nominees Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Aircraft lease agreement relating to one boeing 737-300 aircraft with manufacturer's serial no: 24059 and UK registration mark g-stra (the "aircraft")
    Erstellt am 02. Apr. 2002
    Geliefert am 18. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The lessor's moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • K G Aircraft Leasing Co., Limited
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASTRAEUS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Mai 2013Ende der Verwaltung
    22. Nov. 2011Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Mark Nicholas Cropper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    13. Mai 2013Beginn der Liquidation
    20. Juni 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Mark Nicholas Cropper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0