HIGH STREET LETTINGS LIMITED

HIGH STREET LETTINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIGH STREET LETTINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04382389
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIGH STREET LETTINGS LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HIGH STREET LETTINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGH STREET LETTINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIGH STREET LETTINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. März 2016

    Kapitalaufstellung am 17. März 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. März 2015

    Kapitalaufstellung am 24. März 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. März 2014

    Kapitalaufstellung am 25. März 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Antonio Debiase am 19. Apr. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Antonio Debiase am 19. Apr. 2012

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Philip Howard Black am 19. Apr. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HIGH STREET LETTINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DEBIASE, Antonio
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    Sekretär
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    British34477220009
    BLACK, Philip Howard
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    Geschäftsführer
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    United KingdomBritish87058240005
    DEBIASE, Antonio
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    Geschäftsführer
    Prince Albert House, 20 King
    Street, Maidenhead
    SL6 1DT Berkshire
    United KingdomBritish34477220009
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLACK, Michelle
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    Geschäftsführer
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    British87058320001
    DEBIASE, Joanna Mary Louise
    The Paddock
    Boyn Hill Avenue
    SL6 4HA Maidenhead
    Geschäftsführer
    The Paddock
    Boyn Hill Avenue
    SL6 4HA Maidenhead
    EnglandBritish34477210004

    Hat HIGH STREET LETTINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 25-27 high street harbourne. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 11. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being 14 ancaster way north luffenham oakham leics fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 11. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 22. Apr. 2004
    Geliefert am 11. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1083 bristol road selly oak birmingham.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 11. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 21. Apr. 2004
    Geliefert am 05. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 muscott grove horborne birmingham B17 9RT fixed charge all rental income and floating charge undertaking all other property assets and rights not charged by way of fixed charge above.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 05. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 23. Jan. 2004
    Geliefert am 07. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    25 moorpool avenue, harborne, birmingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 22. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 muscott grove harborne birmingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 2003
    Geliefert am 18. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at 1083 bristol road selly oak birmingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2002
    Geliefert am 21. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £100,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    43 hampton court road, harborne, birmingham.
    Berechtigte Personen
    • Britannic Money PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 10. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a 43 hampton court road, birmingham,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0