CHORION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHORION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04383538
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHORION LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich CHORION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHORION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHORION PLC16. Mai 200216. Mai 2002
    NEW CHORION PLC27. Feb. 200227. Feb. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHORION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHORION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    41 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2019

    23 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2018

    23 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    12 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    11 Seiten600

    Gerichtsbeschluss

    S1096 Court Order to Rectify
    7 SeitenOC

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    9 SeitenLIQ10

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2017

    18 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2016

    21 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2015

    25 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2014

    25 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2013

    25 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Aldwych House 81 Aldwych London WC2B 4HN* am 09. Aug. 2012

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Feb. 2012

    15 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. März 2012

    Kapitalaufstellung am 15. März 2012

    • Kapital: GBP 8,069,042
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2011 bis 25. März 2011

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr Martyn Everett als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Beale als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Philip Beale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CHORION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOWNING, Terry William
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Geschäftsführer
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    United KingdomBritish109287950001
    DURKAN, Mary Margaret
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish42948540002
    EVERETT, Martyn John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish30098070003
    BANKS, Jeremy Loch Mansell
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    Sekretär
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    British66985130003
    BEALE, Philip Arthur
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    Sekretär
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    British50643540001
    MURPHY, Susan Margaret
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    British49990470002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Bevollmächtigter Sekretär
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    ALLI, Waheed, Lord
    Apartment 41-42 Harlequin Court
    20 Tavistock Street
    WC2E 7NZ London
    Geschäftsführer
    Apartment 41-42 Harlequin Court
    20 Tavistock Street
    WC2E 7NZ London
    United KingdomBritish78970290002
    ASTOR, William Waldorf, Viscount
    Ginge Manor
    Ginge
    OX12 8QT Wanton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Ginge Manor
    Ginge
    OX12 8QT Wanton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish81094350001
    BANKS, Jeremy Loch Mansell
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    Geschäftsführer
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    British66985130003
    BEALE, Philip Arthur
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    Geschäftsführer
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    United KingdomBritish50643540001
    LLEWELLYN-LLOYD, Edward John
    13 Calverley Park
    TN1 2SH Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    13 Calverley Park
    TN1 2SH Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish8369250002
    MCGUINNESS, Andrew Peter
    10 Walkers Road
    AL5 1QH Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    10 Walkers Road
    AL5 1QH Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish98443810001
    MURPHY, Susan Margaret
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish49990470002
    TAMBLYN, Nicholas
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish27144350003
    TURNER, Jane Elizabeth
    Flat 4 133 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QJ London
    Geschäftsführer
    Flat 4 133 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QJ London
    EnglandBritish123756290001
    WHITE, Madeleine
    Dolphin House Smugglers Way
    SW18 1DF London
    43
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dolphin House Smugglers Way
    SW18 1DF London
    43
    United Kingdom
    United KingdomNorwegian134780580001
    WILLIAMS, Nicholas James
    13 St Katherine's Way
    E1W 1LP London
    Geschäftsführer
    13 St Katherine's Way
    E1W 1LP London
    British70374720003
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    Geschäftsführer
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    77390740003

    Hat CHORION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second supplemental debenture
    Erstellt am 07. Mai 2010
    Geliefert am 14. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Leveraged Loans Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 14. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. Okt. 2008
    Geliefert am 24. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Leveraged Loans Limited (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2006
    Geliefert am 20. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • G E Leveraged Loans Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries(Security Agent)
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 02. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Leveraged Loans Limited (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2006
    Geliefert am 08. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Leveraged Loans Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 08. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge in relation to intellectual property rights and related rights
    Erstellt am 28. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all intellectual property rights in the works present and future and all licences present or future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CHORION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Juli 2012Beginn der Liquidation
    16. Jan. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praktiker
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0