GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04383834 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 73 Cornhill EC3V 3QQ London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GILBRAN (OXFORD) LIMITED | 28. Feb. 2002 | 28. Feb. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Harley Street London W1G 9BR zum 73 Cornhill London EC3V 3QQ am 11. Feb. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2014 bis 31. Okt. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Gibson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Bailey als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Nigel Preston | Geschäftsführer | 3 Astwood Mews SW7 4DE London | United Kingdom | British | Company Director | 60518560003 | ||||
GIBSON, Hilary Mary | Sekretär | 19 Kingswood Road Clapham SW2 4JE London | British | Office Manager | 75502040001 | |||||
HART, Harry Bimbo | Sekretär | 54a Elizabeth Street SW1W 9PB London | British | Company Director | 32211800004 | |||||
CHALFEN SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013320001 | |||||||
BAILEY, Steven | Geschäftsführer | Sutton Lane North W4 4HF London Winchcombe House | England | British | Consultant | 136498970001 | ||||
BUTTON, Jason | Geschäftsführer | 105 The Ashway NN6 9UZ Brixworth Northamptonshire | England | British | Company Director | 102221990001 | ||||
GIBSON, Hilary Mary | Geschäftsführer | 19 Kingswood Road Clapham SW2 4JE London | British | Office Manager | 75502040001 | |||||
HART, Harry Bimbo | Geschäftsführer | 54a Elizabeth Street SW1W 9PB London | United Kingdom | British | Company Director | 32211800004 | ||||
CHALFEN NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013310001 |
Hat GILBRAN (PLYMOUTH) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 21. Apr. 2006 Geliefert am 26. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (including the company) to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of tavistock road plymouth t/no DN501807. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 05. Aug. 2005 Geliefert am 09. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of rights under a contract for works | Erstellt am 08. März 2005 Geliefert am 09. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All or any of the right, title, benefit and interest of the company whatsoever whether present or future, proprietary, contractual or otherwise, arising out of or in, to or under an agreement dated 24 august 2004 made between midas construction limited and the company;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of rights under a performance bond | Erstellt am 04. Jan. 2005 Geliefert am 05. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A guarantee dated 25TH october 2004. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of rights | Erstellt am 24. Aug. 2004 Geliefert am 10. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben An agreement dated 20 august 2004 between city west country limited and the company including all or any moneys arising out of the contract, all or any claims for damages and rights and remedies for enforcing the contract, rights title and benefits in all guarantees,mortgages, charges and other security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Aug. 2004 Geliefert am 10. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit | Erstellt am 24. Aug. 2004 Geliefert am 10. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee including the sum of £2,474,500.00 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All other amounts standing to the credit of the account together with any interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Aug. 2004 Geliefert am 10. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F.h land k/a site b, the lozenge site, tavistock road, derriford, plymouth, t/no DN462354 and all buildings, all plant, machinery, fixtures, fittings amd other equipment, by way of assignment all options, agreements and benefits of insurance, all rents, licence fees, service charges and other monies and all interest charged under the charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0