TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED

TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04387215
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HALLCO 728 LIMITED05. März 200205. März 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 07. Mai 2015

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Mai 2015

    11 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2015

    11 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2014

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2014

    11 Seiten2.24B

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    5 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    5 SeitenRM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2013

    10 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2013

    11 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2012

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2012

    10 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Nov. 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Mai 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    2 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    42 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    17 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Riverside House 11-12 Riverside Road Norwich Norfolk NR1 1SQ* am 24. Nov. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Vanessa Fletcher als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 2
    • Kapital: USD 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Ian Fox als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    British60588430004
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish60588430004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish52621450004
    FURNESS, Deborah Jane
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    Sekretär
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    British70000190002
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    FLETCHER, Vanessa Anne
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    Geschäftsführer
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    EnglandBritish101139900001
    FOX, Ian Stuart
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    Geschäftsführer
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    EnglandBritish154671930001
    NAVIEDE, Justine Penrose
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish36734870001
    SMITH, Warren James, Lord Lieutenant
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    EnglandBritish14246400001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Hat TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 09. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from targetfollow (regional) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 58-60 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h longsight shopping centre stockport road manchester t/no GM303049 together with all buildings erections and fixtures and fittings (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant equipment and machinery. All monies deposited with the trustee. Floating charge the whole of the company's undertaking.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 09. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from targetfollow (regional) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/s in respect of l/h 58-60 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h longsight shopping centre stockport road manchester t/no GM303049. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge not registered at companies house
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Ausstehend
    Transaktionen
    • Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 207. Dez. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 06. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H interest in 58/66 lime street liverpool t/no MS379776 and l/h interest in longsight shopping centre manchester t/no GM303049 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2002
    Geliefert am 05. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Freehold property being 70 church street runcorn title number CH394905 springfield garages woodhouse lane wigan title number GM233400 castle street shrewsbury title number SL36008 for further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 09. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent assignment deed
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 01. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit of all rent and other sums arrears value added tax interest and insurance monies arising from leases licences and other occupational arrangements in respect of the properties listed in the schedule attached to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a longsight district shopping centre on the east side of stockport road, manchester t/n GM303049, assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amending deed relating to the legal mortgage dated 18 december 1998
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold land and buildings known as longsight district shopping centre on the east side of stockport road,manchester; t/no gm 303049. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amending deed relating to legal mortgage dated 24 february 1998
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold land and buildings known as 58/66 lime street,liverpool; t/no ms 379776; f/hold land and buildings known as 70 church street,runcorn; ch 384905. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amending deed relating to the legal mortgage dated 26 october 1995
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land with buildings thereon and known as 18-20 castle street,shrewsbury,shropshire; sl 36008. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amending deed relating to the legal charge dated 27 january 2000
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property land and buildings on the westerly side of woodhouse lane,wigan; t/no gm 233400; all rights,buildings,fixtures,fittings,plant and machinery thereon; all gross rents licence fees and other monies receivable at any time in respect of any lease of the property or any agreement for lease; the benefit of all guarantees warranties rights or remedies and all plant,machinery,fixtures,fittings and other items; the proceeds of any claim,benefit of any agreements and all sums paid thereunder and all right,title and interest in and to all payments made under any insurance policies in respect of all property assets debts rights and undertaking; the goodwill of business and all licences and all funds standing to the credit of the company on any account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TARGETFOLLOW (NORTH) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Nov. 2010Beginn der Verwaltung
    07. Mai 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    55 Baker Street
    W14 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W14 7EU London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Receiver Manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Receiver Manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0