LINDEN NEW HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLINDEN NEW HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04391802
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PITCOMP 281 LIMITED11. März 200211. März 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cowley Business Park Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AL am 20. Sept. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Sept. 2012

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. März 2012

    Kapitalaufstellung am 07. März 2012

    • Kapital: GBP 2,500,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Ian Baker als Geschäftsführer am 31. Jan. 2012

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul David Cooper am 28. Feb. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Dylan May am 28. Feb. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Baker am 28. Feb. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von David Tilman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Paul Money als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von LINDEN NEW HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COOPER, Paul David
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72568660003
    MAY, Dylan
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    London Road
    AL1 1NS St Albans
    72
    Hertfordshire
    EnglandBritish140361960001
    AMATO, Sylvano
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    Sekretär
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    British83551050001
    MONEY, Paul David
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    Sekretär
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    British123128360001
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Sekretär
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    British73880040001
    STONE, Zillah Wendy
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    Sekretär
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    British55643660001
    PITSEC LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Sekretär
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    38734010001
    AMATO, Silvano
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritish156018520002
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Geschäftsführer
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BAKER, Ian
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish104527410004
    COATES, Christopher
    Chiltern House
    Maltmans Lane
    SL9 8RS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Chiltern House
    Maltmans Lane
    SL9 8RS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish46902170003
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DAVIES, Philip James
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    EnglandBritish115123570001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    British73880040001
    PETTIFOR, Mark Andrew
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    EnglandBritish76909360002
    PRICE, Gerard Colquhoun
    Columbus
    Byfleet Road
    KT11 1EE Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Columbus
    Byfleet Road
    KT11 1EE Cobham
    Surrey
    British82069070003
    TILMAN, David Ward
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish81215590001
    CASTLE NOTORNIS LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Geschäftsführer
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    39348570001

    Hat LINDEN NEW HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 04. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    584 wells road whitchurch t/no BL91718,the enterprise bedminster t/no AV224682,sheepway portishead (moor farm portbury common portishead) t/no ST251735,dover court t/no AV11059 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 30. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("Security Trustee")
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as holmethorpe redhill t/n SY694231 & t/n SY613043. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2004
    Geliefert am 05. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property at park road timperley altrincham t/n GM597073. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 2004
    Geliefert am 31. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property at walnut tree close, guildford t/nos SY702678, SY490054, SY494683 and SY455384 and the unregistered land shown hatched black on plan b annexed to the charge as the property is shown outlined in red on plan a annexed to the charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andthe Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold property at park road timperley altrincham t/n GM94759.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 08. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at park road, timperley, trafford.
    Berechtigte Personen
    • Countryside Residential (North West) Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over beneficial interest
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from linden homes north west limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Beneficial interest in the f/h properties k/a 36 and 38 alexandra road south whalley range t/nos LA5234 and GM857451 and 398 and 400 wilmslow road withington manchester t/no LA339156 and the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge by way of mortgage
    Erstellt am 13. Jan. 2003
    Geliefert am 21. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £10,594,700 and interest thereon due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as land at metropolitan station approach and 129 rickmansworth road watford being the whole of the land comprised within title numbers HD374400 HD333992 and HD383608 and part of the land registered under title number HD371107 and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon.
    Berechtigte Personen
    • London Underground Limited
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 2003
    Geliefert am 15. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at metropolitan station approach watford t/n HD371107 HD374400 HD333992 and HD383608.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Mai 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andeach of the Lenders (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 08. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as former bt side filton road horfield bristol; t/nos BL53409 and BL66225.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LINDEN NEW HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Apr. 2013Aufgelöst am
    04. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Leslie Smith
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Praktiker
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Peter John Godfrey-Evans
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Praktiker
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0