DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04401640 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TRUSTMARQUE ACQUISITIONS LIMITED | 04. Apr. 2002 | 04. Apr. 2002 |
BROOMCO (2860) LIMITED | 22. März 2002 | 22. März 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Dez. 2016 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT zum 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG am 05. Dez. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 044016400008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Dez. 2015
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN zum Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT am 04. Jan. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin John Trainer als Geschäftsführer am 14. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Charles Mills als Sekretär am 14. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dermot James Joyce als Geschäftsführer am 14. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed trustmarque acquisitions LIMITED\certificate issued on 11/12/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Christopher Michael Woolley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Martin Simpson als Geschäftsführer am 26. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Dermot James Joyce am 11. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Charles Mills am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Christopher Michael Woolley am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Martin John Trainer am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Dermot James Joyce am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGUSON, Paul John | Sekretär | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | British | 84739280002 | ||||||
GODLIMAN, Victoria | Sekretär | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | 167818480001 | |||||||
METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Sekretär | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | British | 73646130001 | ||||||
MILLS, Peter Charles | Sekretär | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | 191202760001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
BLOW, Bridget Penelope | Geschäftsführer | Flat 119 B Central 38 Paradise Street B1 2AF Birmingham West Midlands | England | British | Chief Executive | 115125670001 | ||||
COOKE, Ursula | Geschäftsführer | 70 Bootham YO30 7DF York | British | Sales Director | 115125770002 | |||||
FERGUSON, Paul John | Geschäftsführer | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | England | British | Accountant | 84739280002 | ||||
FINLAYSON, David John Mcintosh | Geschäftsführer | 8 Greenfields New Barn Lane Prestbury GL52 3LG Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 33124430005 | |||||
GODLIMAN, Victoria | Geschäftsführer | Triune Court Monks Cross Drive, Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House Yorkshire England | England | British | Accountant | 83684440003 | ||||
HADDOW, Scott William | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8LY Knutsford Spinney End Cheshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 121651070002 | ||||
JOYCE, Dermot James | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | Irish | Ceo | 181301350001 | ||||
LIGERTWOOD, Mark Murray | Geschäftsführer | 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Saltire Court Midlothian Scotland | United Kingdom | Uk | Investment | 179214640001 | ||||
LLOYD, Colin Thomas | Geschäftsführer | Fawke Common Underriver TN15 0JX Sevenoaks Fawke House Kent | United Kingdom | British | Director | 3616430001 | ||||
METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Geschäftsführer | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | United Kingdom | British | Businessman | 73646130001 | ||||
MILLER, Ross Charles | Geschäftsführer | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | Managing Director | 84739210001 | ||||
ROGERS, Christine Margaret | Geschäftsführer | The Old Granary Chilton Road HP18 0DN Chearsley Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 66374680002 | ||||
SIMPSON, Neil Martin | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | United Kingdom | British | Group Commercial Director | 183192810001 | ||||
TRAINER, Martin John | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | Cfo | 124180840001 | ||||
WOOLLEY, James Christopher Michael | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7AN London 1st Floor England | England | British | Director | 156851530001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2014 Geliefert am 19. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 17. Juli 2013 Geliefert am 19. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque acquisitions limited.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 07. Juni 2013 Geliefert am 14. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Aug. 2006 Geliefert am 18. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of securities | Erstellt am 12. Aug. 2006 Geliefert am 18. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Its whole right title and benefit of the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. Juni 2002 Geliefert am 09. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Juni 2002 Geliefert am 11. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 17. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat DORMANT COMPANY 04401640 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0