PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED

PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04401961
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    • Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brookfield Court Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PRIMARY BROKER SERVICES LIMITED 22. März 200222. März 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Shane O’Neill als Direktor am 24. Okt. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy John Smyth als Geschäftsführer am 24. Okt. 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Penelope Jane Fullerton als Sekretär am 24. Okt. 2022

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England zum Brookfield Court Selby Road Garforth Leeds LS25 1NB am 26. Sept. 2022

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Juli 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. März 2021

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Anne Brophy als Sekretär am 31. Mai 2022

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Penelope Jane Fullerton als Sekretär am 01. Juni 2022

    2 SeitenAP03

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2021 bis 30. März 2021

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Juli 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England zum 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG am 17. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England zum 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG am 17. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England zum 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG am 17. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds LS15 4LG England zum 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG am 17. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England zum 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds LS15 4LG am 17. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE England zum 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG am 03. Aug. 2020

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Juli 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Richard Miles Skingle als Geschäftsführer am 27. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    1 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    O’NEILL, Shane
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Geschäftsführer
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    EnglandIrishCompany Director301599440001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    BritishCompany Secretary139352410001
    BROPHY, Elizabeth Anne
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    247170820001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    Sekretär
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    296527570001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Sekretär
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    184077550001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Sekretär
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Sekretär
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Sekretär
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    185570180001
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Sekretär
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    170325300001
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Sekretär
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    Sekretär
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    37896530011
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BARCLAY, Ian James
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director184779440002
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Geschäftsführer
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritishDirector135540180002
    BIBBY, John
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    BritishCompany Director27995540003
    DAVEY, Jonathan Mark
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81484820003
    DRAKE, Darrell John
    Tithe Barn
    Banbury Road
    CV34 6SU Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Tithe Barn
    Banbury Road
    CV34 6SU Warwick
    Warwickshire
    BritishUnderwriter99764060001
    DWYER, Helen Mary
    The Coach House
    Lodge Lane Dutton
    WA4 4HP Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Coach House
    Lodge Lane Dutton
    WA4 4HP Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director74301990001
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritishFinance Director184068890001
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Geschäftsführer
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    BritishAccountant79523100001
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishExecutive Chairman28375870003
    JEWELL, Paul John
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Geschäftsführer
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritishCompany Director221544490001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Geschäftsführer
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    BritishInsurance Executive127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    Geschäftsführer
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    BritishCompany Director14395670002
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritishFinance Director233726140001
    LEIGHTON, Maria Louise
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director202291580001
    NATHAN, Clive Adam
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director207013760001
    PITT, Richard James
    4 Alhambra Road
    The Oakalls
    B60 2RY Bromsgrove
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Alhambra Road
    The Oakalls
    B60 2RY Bromsgrove
    West Midlands
    BritishManaging Director114691890001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Geschäftsführer
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritishChairman139631580001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director107872640001
    SAGGU, Ranvir Singh
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    Geschäftsführer
    21 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant115958310001
    SKINGLE, Richard Miles
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    Geschäftsführer
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    England
    EnglandBritishFinance Director203052180001
    SMITH, Malachy Paul
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    IrelandIrishNon Executive Director262619320001
    SMYTH, Timothy John
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Geschäftsführer
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    EnglandBritishDirector77794000006
    WARREN, Michael Ian
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Uk
    EnglandBritishChief Operating Officer140310390001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Pbsh Holdings Limited
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast Hose
    England
    06. Apr. 2016
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast Hose
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegister Of Uk Limited Companies
    Registrierungsnummer5297966
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat PRIMARY GENERAL INSURANCE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2007
    Geliefert am 15. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse,London Branch (Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2006
    Geliefert am 02. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Apr. 2005
    Geliefert am 06. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0