TRANFOODS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TRANFOODS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04404213 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRANFOODS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TRANFOODS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Seton House Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Warwick |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRANFOODS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DELEGATION LIMITED | 26. März 2002 | 26. März 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRANFOODS LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2018 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2018 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRANFOODS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Nov. 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 16 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Malcolm Terry als Sekretär am 29. Juni 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Helen Margaret Glennie als Direktor am 29. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Ronald William Francis als Direktor am 29. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Thomas als Geschäftsführer am 29. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Malcolm Terry als Geschäftsführer am 29. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. März 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Malcolm Terry als Direktor am 09. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Herluf Jensen als Geschäftsführer am 09. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Herluf Jensen als Sekretär am 09. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Malcolm Terry als Sekretär am 09. März 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Sept. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 29. Sept. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRANFOODS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | England | British | Director | 205102630001 | ||||
GLENNIE, Helen Margaret | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | England | British | Director | 217903040001 | ||||
DANBY, Ralph Edward | Sekretär | 12 Chestnut Way LS16 7TN Leeds | British | Company Secretary | 29884810006 | |||||
JENSEN, Herluf | Sekretär | Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House Warwickshire Uk | British | 165224900001 | ||||||
TERRY, Christopher Malcolm | Sekretär | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | 206503950001 | |||||||
RWL REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900007870001 | |||||||
BRITTON, Anthony Eric | Geschäftsführer | Sunnyside Main Street Birlby YO42 4JL York Yorkshire | England | British | Sales Director | 83454910001 | ||||
CLARKSON, Andrew | Geschäftsführer | 18 Mossdale Close Great Sankey WA5 3RY Warrington Cheshire | British | Director | 83454730001 | |||||
ENEVOLDSEN, Flemming Nyenstad | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | Denmark | Danish | Ceo | 156168570001 | ||||
JENSEN, Herluf | Geschäftsführer | Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House Warwickshire Uk | England | Danish | None | 96281690001 | ||||
JUST, Christopher | Geschäftsführer | Sutton Hall Sutton Hall Drive,Little Sutton CH66 4UQ Ellesmere Port Cheshire | United Kingdom | British | Director | 69506840001 | ||||
MURRELLS, Steven Geoffrey | Geschäftsführer | Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House Warwickshire Uk | England | British | None | 156162510001 | ||||
PARKER, Richard John | Geschäftsführer | Southcroft 293 Skircoat Green Road HX3 0BW Halifax West Yorkshire | England | British | Sales Director | 21667200002 | ||||
SEPHTON, James Arthur | Geschäftsführer | Frogmore Grange Frogmore Lane Balsall Common CV7 7FP Coventry West Midlands | England | British | Director | 58261140001 | ||||
TERRY, Christopher Malcolm, Mr. | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | England | British | Chartered Accountant | 60746700002 | ||||
THOMAS, Christopher | Geschäftsführer | Warwick Technology Park CV34 6DA Gallows Seton House Warwick | United Kingdom | British | Ceo | 63844650001 | ||||
BONUSWORTH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900006860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRANFOODS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulip Limited | 06. Apr. 2016 | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TRANFOODS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 24. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of its subsidiaries (group members) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/L and buildings on the north side of st. Mary's gate birkenhead t/no:MS325608 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery by way of assignment all rents and other income and the benefit of any lease or licence or occupational lease or licence see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 24. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to santander UK PLC or to any of its subsidiaries ("group members")on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 191-197 (odd) chester street birkenhead t/no:MS458714 and all f/h land on the north side of abbey street birkenhead t/no:MS458713 f/h land and buildings on the south side of st mary's gate and on the north side of abbey street t/no:MS430314 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery by way of assignment all rents and other income and the benefit of any lease or licence or occupational lease or licence see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 23. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Sept. 2007 Geliefert am 27. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a warehouse and storage facility st mary's gate brokenhead merseyside t/no MS325608. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as 191 to 197 chester street birkenhead, t/n MS458714. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as land on the north side of abbey street birkenhead, t/n MS458713. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as land and buildings on the south side of st mary's gate and on the north side of abbey street birkenhead, t/n MS430314. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Nov. 2003 Geliefert am 04. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Juni 2003 Geliefert am 28. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property land and buildings on the north side of st. Mary's gate, birkenhead t/n MS325608. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 22. Aug. 2002 Geliefert am 30. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £573,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Saxon 2000KG capacity scissor lift, dock leveller, jungheinrich pedestrian controlled pallet truck for details of further goods charged please refer to form 395. together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation (or amendments to them) belonging to above items. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 02. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0