BLUE BREEZE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BLUE BREEZE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04410227 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLUE BREEZE LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich BLUE BREEZE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Duff & Phelps Ltd The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLUE BREEZE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLUE BREEZE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 38 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Ciara Fitzgibbon als Direktor am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Kenneth Robertson als Direktor am 05. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Treacy als Geschäftsführer am 05. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Claire Treacy als Direktor am 14. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser James Kennedy als Geschäftsführer am 14. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BLUE BREEZE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Exchange Place 3 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| FITZGIBBON, Ciara | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 225576850001 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| NAIK, Varsha | Sekretär | 14 Brearley Close Pavilion Way HA8 9YT Edgware Middlesex | British | 101693390001 | ||||||||||
| HALCO SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 8-10 New Fetter Lane EC4A 1RS London | 42871950001 | |||||||||||
| BOWMAN, Gary John | Geschäftsführer | Le Pre Du Haut Rue De Grantez JE3 4DG St Owen Jersey Channel Islands | British | 79684770002 | ||||||||||
| CAPPS, David John | Geschäftsführer | Shibui Route De La Villaise JE3 2AP Millais St Ouen Jersey | British | 75686940005 | ||||||||||
| COOMBS-GOODFELLOW, Ian Christopher | Geschäftsführer | Sandhurst Causie Drive St Clement JE2 6SR Jersey Channel Islands | British | 79683160001 | ||||||||||
| CORLETT, Robert John | Geschäftsführer | 102 Deacon Road KT2 6LU Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 72399980002 | |||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| OLIVER, Paul Francis | Geschäftsführer | Curlew House 58 Grove Park Gardens Chiswick W4 3RZ London | United Kingdom | British | 14735150002 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| THOMAS, Andrew James | Geschäftsführer | Longueville Road, St Saviour JE2 7WF Jersey Channel Islands | British | 79683170001 | ||||||||||
| TREACY, Claire | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Geschäftsführer | 31 Chester Way Kennington SE11 4UR London | British | 100816670001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BLUE BREEZE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Partnerships (Osprey) Limited | 06. Apr. 2016 | Manor Court Business Park Eastfield YO11 3TU Scarborough 1st Floor, Unit 16 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BLUE BREEZE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Feb. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south side of king edward street macclesfield t/n CH393674, l/h land on the north east queen street (k/a regent house) barnstaple and l/h land being part of multi-storey car park queen street barnstaple t/n DN276066 and DN311311 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Okt. 2002 Geliefert am 12. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Okt. 2002 Geliefert am 12. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the osprey limited partnership acting by its general partner equity partnerships (osprey) limited to the lenders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 24 witton street northwich and all that l/h property k/a land on the east and west of witton walk northwich. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BLUE BREEZE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0