DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED

DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04413747
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 12 Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE SPECIALIST HIRE GROUP LIMITED18. Nov. 200218. Nov. 2002
    BROOMCO (2898) LIMITED10. Apr. 200210. Apr. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 07. Dez. 2022

    • Kapital: GBP 0.50
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share premium account 07/12/2022
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Re: the sum of £5,200 is hereby capitalised 05/12/2022
    RES14
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Dez. 2022

    • Kapital: GBP 348,081
    3 SeitenSH01

    Ernennung von Damien Joos De Ter Beerst als Direktor am 23. Aug. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Chankyo Chung als Geschäftsführer am 01. Aug. 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    19 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Sangyoung Park als Direktor am 05. Feb. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jae Hun Lee als Geschäftsführer am 05. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Chankyo Chung als Direktor am 14. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Clarkson als Geschäftsführer am 14. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David John Clarkson am 28. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Waples als Geschäftsführer am 28. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOOS DE TER BEERST, Damien
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    BelgiumBelgian299677480001
    PARK, Sangyoung
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandSouth Korean279587030001
    COSGROVE, Lynn
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Sekretär
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    British82671660002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CHAPPELL, John
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomBritish82671440009
    CHUNG, Chankyo
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    BelgiumSouth Korean267295790001
    CLARKSON, David John
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandBritish226255820001
    COSGROVE, Peter
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish82678990001
    FARQUHAR, Graham
    Ravensthorpe Industrial Estate
    Huddersfield Road, Ravensthorpe
    WF13 3LN Dewsbury
    Rushlift Ltd
    Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ravensthorpe Industrial Estate
    Huddersfield Road, Ravensthorpe
    WF13 3LN Dewsbury
    Rushlift Ltd
    Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133936050001
    FARQUHAR, Graham
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomBritish133936050001
    HOLYLAND, Graham Anthony
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish117529920002
    LEE, Jae Hun
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandSouth Korean200052720001
    LOKE, Joanna
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    United KingdomEnglish195167270001
    SHAW, Dennis Charles
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    EnglandBritish87833070001
    SUH, Sungkyo
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    SeoulSouth Korean195430480001
    WAPLES, Timothy Mark
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    Geschäftsführer
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    Unit 12
    England
    EnglandBritish126815020001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LIMITED
    Floor Dorey Court Admiral Park
    St Peter Port
    GY1 6HJ Guernsey
    1st
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Floor Dorey Court Admiral Park
    St Peter Port
    GY1 6HJ Guernsey
    1st
    Channel Islands
    RechtsformNOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LTD
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageLIMITED COMPANY
    Registrierungsnummer44635
    130880920001
    NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LTD
    Strand
    SW1Y 5HF London
    11
    Geschäftsführer
    Strand
    SW1Y 5HF London
    11
    115027450004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Doosan Industrial Vehicle Uk Ltd
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    12
    England
    06. Apr. 2016
    Kilvey Road
    Brackmills Industrial Estate
    NN4 7BQ Northampton
    12
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageLtd Companies Act 2006
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer7646794
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining northgate, white lund industrial estate, morecambe t/n LA926044,fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of further properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC and Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. März 2011
    Geliefert am 01. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 3 south church industrial estate bishop auckland and land at longfield road south church enterprise park bishop auckland t/nos. DU156261 and DU253443 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. März 2011
    Geliefert am 01. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Northgate white lund industrial estate morecambe t/no. LA926044 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2006
    Geliefert am 15. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a northgate white lund industrial estate morecambe lancashire t/no LA926044. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2006
    Geliefert am 15. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 3 south church industrial estate bishop auckland county durham t/no DU156261 and adjoining land t/no DU253443. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (2898) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 17. Juli 2002
    Geliefert am 20. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Halifax life policy number ASSH002071 commenced on 24 june 2002 in respect of peter cosgrove together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 17. Juli 2002
    Geliefert am 20. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Halifax life policy number ASSH002070 commenced on 24 june 2002 in respect of john chappell together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 15. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0