DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04413747 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 12 Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE SPECIALIST HIRE GROUP LIMITED | 18. Nov. 2002 | 18. Nov. 2002 |
| BROOMCO (2898) LIMITED | 10. Apr. 2002 | 10. Apr. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Dez. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Dez. 2022
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Damien Joos De Ter Beerst als Direktor am 23. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Chankyo Chung als Geschäftsführer am 01. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Sangyoung Park als Direktor am 05. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jae Hun Lee als Geschäftsführer am 05. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Chankyo Chung als Direktor am 14. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Clarkson als Geschäftsführer am 14. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John Clarkson am 28. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Waples als Geschäftsführer am 28. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOOS DE TER BEERST, Damien | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | Belgium | Belgian | 299677480001 | |||||||||||||
| PARK, Sangyoung | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | England | South Korean | 279587030001 | |||||||||||||
| COSGROVE, Lynn | Sekretär | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | British | 82671660002 | ||||||||||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollm ächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||||||
| CHAPPELL, John | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | United Kingdom | British | 82671440009 | |||||||||||||
| CHUNG, Chankyo | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | Belgium | South Korean | 267295790001 | |||||||||||||
| CLARKSON, David John | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | England | British | 226255820001 | |||||||||||||
| COSGROVE, Peter | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | England | British | 82678990001 | |||||||||||||
| FARQUHAR, Graham | Geschäftsführer | Ravensthorpe Industrial Estate Huddersfield Road, Ravensthorpe WF13 3LN Dewsbury Rushlift Ltd Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133936050001 | |||||||||||||
| FARQUHAR, Graham | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | United Kingdom | British | 133936050001 | |||||||||||||
| HOLYLAND, Graham Anthony | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | England | British | 117529920002 | |||||||||||||
| LEE, Jae Hun | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | England | South Korean | 200052720001 | |||||||||||||
| LOKE, Joanna | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | United Kingdom | English | 195167270001 | |||||||||||||
| SHAW, Dennis Charles | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 | England | British | 87833070001 | |||||||||||||
| SUH, Sungkyo | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | Seoul | South Korean | 195430480001 | |||||||||||||
| WAPLES, Timothy Mark | Geschäftsführer | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton Unit 12 England | England | British | 126815020001 | |||||||||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||||||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||||||
| NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LIMITED | Geschäftsführer | Floor Dorey Court Admiral Park St Peter Port GY1 6HJ Guernsey 1st Channel Islands |
| 130880920001 | ||||||||||||||
| NOVA GENERAL PARTNER (GUERNSEY) LTD | Geschäftsführer | Strand SW1Y 5HF London 11 | 115027450004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doosan Industrial Vehicle Uk Ltd | 06. Apr. 2016 | Kilvey Road Brackmills Industrial Estate NN4 7BQ Northampton 12 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DOOSAN MATERIALS HANDLING UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 06. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land adjoining northgate, white lund industrial estate, morecambe t/n LA926044,fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of further properties charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 01. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 3 south church industrial estate bishop auckland and land at longfield road south church enterprise park bishop auckland t/nos. DU156261 and DU253443 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 01. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Northgate white lund industrial estate morecambe t/no. LA926044 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 2006 Geliefert am 15. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a northgate white lund industrial estate morecambe lancashire t/no LA926044. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 2006 Geliefert am 15. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 3 south church industrial estate bishop auckland county durham t/no DU156261 and adjoining land t/no DU253443. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Nov. 2002 Geliefert am 22. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (2898) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of life policy | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 20. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Halifax life policy number ASSH002071 commenced on 24 june 2002 in respect of peter cosgrove together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of life policy | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 20. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Halifax life policy number ASSH002070 commenced on 24 june 2002 in respect of john chappell together with all sums assured by the policy and all bonuses and benefits which may arise under it and the company's whole right title and interest present and future in the policy. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juni 2002 Geliefert am 15. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0