COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04414667 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SYDNEY & BIRMINGHAM 2 LIMITED | 11. Apr. 2002 | 11. Apr. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 43 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 11. Apr. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Treacy als Geschäftsführer am 05. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Kenneth Robertson als Direktor am 05. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Claire Treacy als Direktor am 14. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser James Kennedy als Geschäftsführer am 14. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 01. Juli 2013 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Fraser James Kennedy am 01. Juli 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* am 02. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
VALSEC DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom |
| 102622300002 | ||||||||||
CURTIS, Wendy June | Sekretär | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | Company Director | 46982690003 | |||||||||
RICHARDSON, Paul | Sekretär | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
CHALFEN SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013320001 | |||||||||||
ANNING, Richard John | Geschäftsführer | Witchwood Westra CF64 4HA Dinas Powys Vale Of Glamorgan | Wales | British | Property Investment Chartered | 14073020003 | ||||||||
CHILDS, Simon John | Geschäftsführer | 18 Hardwicke Court Llandaff CF5 2LB Cardiff | United Kingdom | British | Accountant | 78425720001 | ||||||||
CURTIS, Wendy June | Geschäftsführer | 136 Henke Court Schooner Way Atlantic Wharf CF10 4EL Cardiff | British | Company Director | 46982690003 | |||||||||
DI CIACCA, Cesidio Martin | Geschäftsführer | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | Solicitor | 1267050001 | ||||||||
KENNEDY, Fraser James | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 121610350003 | ||||||||
MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 56953000002 | ||||||||
MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | Chartered Surveyor | 109250000001 | |||||||||
OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Director | 135717740001 | ||||||||
ROBERTSON, Neil Kenneth | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 158937210001 | ||||||||
SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 41925000003 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
TREACY, Claire | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | Head Of Tax & Risk, Europe | 189529610001 | ||||||||
CHALFEN NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013310001 | |||||||||||
EUROPA DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
Hat COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 22. März 2012 Geliefert am 30. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession and charge | Erstellt am 28. Aug. 2009 Geliefert am 11. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 22. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 22. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998) | Erstellt am 16. Apr. 2002 Geliefert am 27. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over shares | Erstellt am 16. Apr. 2002 Geliefert am 27. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 16. Apr. 2002 Erworben am 16. Apr. 2002 Geliefert am 24. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0