COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED

COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04414667
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SYDNEY & BIRMINGHAM 2 LIMITED11. Apr. 200211. Apr. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    43 Seiten4.71

    Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 11. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 22. März 2016

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Claire Treacy als Geschäftsführer am 05. Jan. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Neil Kenneth Robertson als Direktor am 05. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Claire Treacy als Direktor am 14. Aug. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Fraser James Kennedy als Geschäftsführer am 14. Aug. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 01. Juli 2013

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Fraser James Kennedy am 01. Juli 2013

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* am 02. Juli 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Sekretär
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300002
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Sekretär
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    BritishCompany Director46982690003
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Sekretär
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    CHALFEN SECRETARIES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013320001
    ANNING, Richard John
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishProperty Investment Chartered14073020003
    CHILDS, Simon John
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    Geschäftsführer
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    United KingdomBritishAccountant78425720001
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    Geschäftsführer
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    BritishCompany Director46982690003
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Geschäftsführer
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Geschäftsführer
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishHead Of Tax & Risk, Europe189529610001
    CHALFEN NOMINEES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013310001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Hat COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 30. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 30. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 11. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998)
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over shares
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Erworben am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 24. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 31. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. März 2016Beginn der Liquidation
    30. Juli 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0