DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04421854 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Severn Trent Centre St. Johns Street CV1 2LZ Coventry England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INTERCEDE 1788 LIMITED | 22. Apr. 2002 | 22. Apr. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2023 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 248 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2022 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 240 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2021 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 244 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Anthony Jackson als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Adam Peter Stephens als Direktor am 31. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 208 Seiten | PARENT_ACC | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE, Gemma Louise | Sekretär | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | 227678690001 | |||||||||||
MCPHEELY, Robert Craig | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | Accountant | 104273610001 | ||||||||
STEPHENS, Adam Peter | Geschäftsführer | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 281599070001 | ||||||||
BICKERTON, Andrew Alan | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | 188745400001 | |||||||||||
GUEST, David James | Sekretär | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | British | Accountant | 6573790001 | |||||||||
PLENDERLEITH, Ian John Alexander | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | 209226770001 | |||||||||||
STRAHAN, David Edward | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | 174728660001 | |||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||||||
BICKERTON, Andrew Alan | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 187480330001 | ||||||||
DOVEY, Mark James, Mr. | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | Company Director | 166254070001 | ||||||||
GOWER, Adrian Walton | Geschäftsführer | 3 Windmill Road TW8 0QD Brentford Middlesex | British | Trust Official | 101422170001 | |||||||||
GUEST, David James | Geschäftsführer | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | England | British | Accountant | 6573790001 | ||||||||
HILLS, Peter Michael | Geschäftsführer | 66 Hartslock Drive Thamesmead SE2 9UU London | British | Trustee Official | 48947040001 | |||||||||
HOWARTH, Stuart Belton, Dr | Geschäftsführer | Chapel House Threapwood SY14 7AX Malpas Cheshire | United Kingdom | British | Director | 37875800001 | ||||||||
JACKSON, John Anthony | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | United Kingdom | Irish | Company Director | 190509470001 | ||||||||
JENKINS, Brian Stuart | Geschäftsführer | Beeston House CW6 9ST Tarporley Cheshire | British | Accountant | 14981320001 | |||||||||
NEEDHAM, Bryan Donald | Geschäftsführer | Riverside Cottage Zephon Common GU51 5SX Crookham Village Fleet Hampshire | England | British | Trustee Official | 38629530001 | ||||||||
PLENDERLEITH, Ian John Alexander | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | England | British | Chief Executive | 236145970001 | ||||||||
STRAHAN, David Edward | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Clwyd | Northern Ireland | British | Finance Director | 145588240001 | ||||||||
CAPITA TRUST COMPANY LIMITED | Geschäftsführer | Guildhall House 81-87 Gresham Street EC2V 7QE London Guildhall House United Kingdom |
| 82708370001 | ||||||||||
CAPITA TRUST CORPORATE LIMITED | Geschäftsführer | 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent England |
| 109010570001 | ||||||||||
CAPITA TRUST CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | The Registry 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent United Kingdom |
| 114688040003 | ||||||||||
MITRE DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900024450001 | |||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chester Water Limited | 06. Apr. 2016 | Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Packsaddle Wales | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat DEE VALLEY WATER (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Holdco debenture | Erstellt am 25. Juni 2002 Geliefert am 28. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Borrower security trust and intercreditor deed between the company, dee valley water PLC, (the "borrower") chester water PLC, capital irg trustees limited (the "borrower security trustee") and the royal bank of scotland PLC (the "borrower stid") | Erstellt am 19. Juni 2002 Geliefert am 27. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future sums liabilities and obligations due or to become due from the borrower or the company to the chargee , any acceding creditor, any qualifying debt holder and any qualifying debt representative or to any intra-group subordinated creditor and any non-group subordinated creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any payments distributions (whether by way of set-off or otherwise). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0