BISHOPSGATE PARKING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBISHOPSGATE PARKING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04422293
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SHARESCREEN LIMITED23. Apr. 200223. Apr. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Feb. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 27. Aug. 2014

    18 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Aug. 2014

    18 Seiten2.24B

    Erfüllung der Belastung 34 vollständig

    4 SeitenMR04

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2014

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Sept. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Apr. 2013

    21 Seiten2.24B

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Beendigung der Bestellung von Benjamin Broader als Geschäftsführer am 14. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Vorschlag des Verwalters

    52 Seiten2.17B

    legacy

    62 SeitenMG06

    legacy

    58 SeitenMG06

    legacy

    58 SeitenMG06

    legacy

    65 SeitenMG06

    legacy

    54 SeitenMG06

    legacy

    51 SeitenMG06

    Wer sind die Geschäftsführer von BISHOPSGATE PARKING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ACCOMPLISH SECRETARIES LIMITED
    South Street, Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Sekretär
    South Street, Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5752036
    121109170001
    BAILIE, Mark Mccracken
    43 Frankfurt Road
    SE24 9NX London
    Sekretär
    43 Frankfurt Road
    SE24 9NX London
    British75972750001
    BARTLETT, Paul Eugene
    16 Oster Street
    AL3 5JL St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    16 Oster Street
    AL3 5JL St Albans
    Hertfordshire
    British54206450004
    WARREN, Georgia
    6 Grange Fields
    SL9 9AG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Sekretär
    6 Grange Fields
    SL9 9AG Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British81882060001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Sekretär
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROADER, Benjamin
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IsraelBritish165999470001
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish53756030002
    CULLINAN, Rory Malcolm
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    Geschäftsführer
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    EnglandBritish149327390001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Geschäftsführer
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FEGGETTER, Fiona
    81c London Road
    Forest Hill
    SE23 3UZ London
    Geschäftsführer
    81c London Road
    Forest Hill
    SE23 3UZ London
    British81882070001
    GIFFIN, David Ronald
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish65377070001
    GREENSHIELDS, John Fraser
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    Geschäftsführer
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    British62806730003
    MACRAE, Gregor Charles William
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish151235850002
    MURRAY, Sean Anthony
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish67091270001
    PECKHAM, Simon Antony
    White Cottage
    9 Meadway
    KT22 0LZ Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Cottage
    9 Meadway
    KT22 0LZ Oxshott
    Surrey
    British44948450001
    ROBERTSON, Ian Leith Johnston
    14 March Pines
    EH4 3PF Edinburgh
    Geschäftsführer
    14 March Pines
    EH4 3PF Edinburgh
    British84831140001
    RUDGE, David
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritish58543980004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    ULTRALINK LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Geschäftsführer
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023330001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Geschäftsführer
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001

    Hat BISHOPSGATE PARKING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of rents intimation dated 7 april 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 25. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Acting as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents intimation dated 7 april 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 25. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents intimation dated 7 april 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 25. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental standard security (incorporating deed of variation) which was presented for registration in scotland on the 14TH march 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 22. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Car park on the north west side of willison street dundee t/n ANG4832.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental standard security (incorporating deed of variation) which was presented for registration in scotland on the 14TH march 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 22. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Multi-storey car park at 81-83 mitchell street glasgow t/n gla 144769.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental standard security (incorporating deed of variation) which was presented for registration in scotland on the 14TH march 2005 and
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 22. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Multi-storey car park on the east side of oswald street glasgow t/n GLA109889.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 16. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries, the mezzanine beneficiaries, the hillstep senior beneficiaries the hillstep stretch senior beneficiaries and the hillstep mezzanine beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 6 dublin road mscp belfast t/no. AN61821 county antrim the l/h property k/a 7 montgomery st. Belfast t/no AN22053L county antrim. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 16. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries, the mezzanine beneficiaries, the hillstep senior beneficiaries the hillstep stretch senior beneficiaries and the hillstep mezzanine beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 3 arthur court t/n NGL683401, the f/h property k/a 4 cotton st. Ashton-under-lyne t/n GM620004, l/h property k/a 10 albany birmingham t/n WM677633 and WM677637 for further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental charge
    Erstellt am 25. März 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from powerfocal to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additonal property (f/h property plot 402 spinningfields manchester t/n's GM852579, GM925600 and GM905307). By way of security assignments the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments (No. 2) Limited (the Beneficiary)
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental charge
    Erstellt am 25. März 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additonal property (f/h property plot 402 spinningfields manchester t/n's GM852579, GM925600 and GM905307). By way of security assignments the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 january 2004 and
    Erstellt am 10. Nov. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from powerfocal limted to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the car park at willison street, dundee t/no ang 4835.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments No 2 Limited
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30TH january 2004 and
    Erstellt am 10. Nov. 2003
    Geliefert am 10. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Multi storey car park 81-83 mitchell street glasgow t/n GLA144769.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments No 2 Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30TH january 2004 and
    Erstellt am 10. Nov. 2003
    Geliefert am 10. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Multi storey car park oswald street glasgow t/n GLA109889.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments No 2 Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third party security
    Erstellt am 10. Nov. 2003
    Geliefert am 28. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from powerfocal to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 3 arthur court t/n NGL683401, f/h 4 ashton-under-lyne cotton st t/n GM620004, l/h 10 birmingham albany t/n WM677633 and WM677637 (please refer to the formn 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third party security
    Erstellt am 10. Nov. 2003
    Geliefert am 28. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from powerfocal to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 6 belfast dublin rd mscp t/n AN61821 county antrim, l/h 7 belfast montogomery st t/n AN22053L county antrim. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Erstellt am 25. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the car park on the northwest side of willison street, dundee t/n ANG4835.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC *as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Erstellt am 25. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the multi storey car park at 81-83 mitchell street, glasgow t/n GLA144769.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Erstellt am 25. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the multi storey car park on the east side of oswald street, glasgow t/n GLA109889.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents intimated on 14 november 2003 and
    Erstellt am 24. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the mezzanine beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Trustee for the Beneficiaries, and Its Successors, Transfereesfrom Time to Time
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents intimated on 14 november 2003 and
    Erstellt am 24. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the mezzanine beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Trustee for the Beneficiaries, and Its Successors, Transfereesfrom Time to Time
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents intimated on 14 november 2003 and
    Erstellt am 24. Sept. 2003
    Geliefert am 29. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the mezzanine beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rents.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Trustee for the Beneficiaries, and Its Successors, Assignees Andtransferees from Time to Time
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 2003
    Geliefert am 22. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Arthur court t/n NGL683401, ashton-under-lyne cotton st t/n GM620004, birmingham albany t/n's WM677633 and WM677637 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets, investments, intellectual property and uncalled capital, distributions, debts, the accounts and any other accounts of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat BISHOPSGATE PARKING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Aug. 2014Ende der Verwaltung
    19. Okt. 2012Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0