MODUS GREGORY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMODUS GREGORY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04424251
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MODUS GREGORY LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich MODUS GREGORY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MODUS GREGORY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INHOCO 2640 LIMITED25. Apr. 200225. Apr. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MODUS GREGORY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für MODUS GREGORY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Aug. 2010

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Edge Clowes Street Manchester M3 5NB am 27. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. Aug. 2010

    LRESEX

    Beendigung der Bestellung von James Riddell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Mcgawley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Damian Flood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 08. Juni 2010

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(287)

    Wer sind die Geschäftsführer von MODUS GREGORY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, John Elwyn
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    British84729210001
    FLOOD, Brendan
    Mowbray
    Leigh Road Worsley
    M28 2QU Manchester
    Geschäftsführer
    Mowbray
    Leigh Road Worsley
    M28 2QU Manchester
    EnglandBritishProperty Developer38787790002
    FLOOD, Brendan
    40 Cavendish Road Ellesmere Park
    Eccles
    M30 9JF Manchester
    Sekretär
    40 Cavendish Road Ellesmere Park
    Eccles
    M30 9JF Manchester
    BritishProperty Developer38787790001
    GREGORY, George Barry
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    Sekretär
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    BritishCompany Director29331210001
    ROBERTSON, Marjorie
    78 Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    Sekretär
    78 Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    BritishAccountant72111170002
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    FLOOD, Damian
    4 New Bank Close
    Dobcross
    OL3 5LE Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 New Bank Close
    Dobcross
    OL3 5LE Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishProperty Developer99422430001
    GREGORY, George Barry
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director29331210001
    MCGAWLEY, Richard Thomas
    6 Robert Moffat
    High Legh
    WA16 6PS Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Robert Moffat
    High Legh
    WA16 6PS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director70917180001
    RIDDELL, James Michael Charles
    Brook Road
    WA13 9AH Lymm
    2
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brook Road
    WA13 9AH Lymm
    2
    Cheshire
    EnglandBritishProperty Manager60942110002
    WILKINSON, Peter John Byrne
    2 Haworth Grove
    Heaton
    BD9 5PE Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Haworth Grove
    Heaton
    BD9 5PE Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director9269380001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Hat MODUS GREGORY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge (third party)
    Erstellt am 04. Dez. 2008
    Geliefert am 19. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from modus properties limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land on the north side of high street west, on the east side of glossop brook road, on the north west side of wrens west road and on the west side of shrewsbury street, glossop t/no DY205877 by way of fixed charge the goodwill.by way of floating charge all plant machinery equipment furniture and other chattel assets.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 128. Aug. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Charge of building contract
    Erstellt am 12. Jan. 2005
    Geliefert am 18. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns the right title and interest in and to a building contract dated 17 november 2004 and a performance bond dated 16 december 2004 and all money pursuant to the agreements and all contracts present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of agreements
    Erstellt am 18. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The agreements and other documents granted in relation to the f/h and l/h land and premises at wren nest retail park glossop derbyshire and all money pursuant to the agreement. The agreements being 1. an agreement for lease underlease and sale dated 30 april 2004 made between (1) modus gregory limited (2) oakapple homes (glossop) limited (3) oakapple estates limited and (4) modus properties limited and gregory property holdings limited 2. an escrow deed dated 18 august 2004 made between (1) modus gregory limited (2) oakapple homes (glossop) limited (3) barclays bank limited 3. a legal charge over land adjacent to the property dated 18 august 2004 made between (1) oakapple homes (glossop) limited and (2) modus gregory limited.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of agreement for lease
    Erstellt am 18. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The agreements and other documents for the grant of a lease or leases of property k/a the f/h and l/h land and premises at wren nest retail park glossop derbyshire and all money due pursuant to the agreement. The agreements being 1. agreement for lease relating to unit a dated 1 august 2003 between (1) the company and (2) focus (diy) limited 2. agreement for lease relating to unit b dated 4 june 2004 between (1) the company and (2) next group PLC. For details of further agreements charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h land and premises to be known as wren nest retail park glossop derbyshire. For further details of the property charged please refer to form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MODUS GREGORY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Receiver Manager
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Receiver Manager
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DatumTyp
    11. Aug. 2010Beginn der Liquidation
    03. Juni 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary Norton Lee
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Stephen Leonard Conn
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0