MODUS GREGORY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MODUS GREGORY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04424251 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MODUS GREGORY LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich MODUS GREGORY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 340 Deansgate M3 4LY Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MODUS GREGORY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INHOCO 2640 LIMITED | 25. Apr. 2002 | 25. Apr. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MODUS GREGORY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MODUS GREGORY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Aug. 2010 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | LQ02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Edge Clowes Street Manchester M3 5NB am 27. Aug. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Riddell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Mcgawley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damian Flood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 08. Juni 2010 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 405(1) | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(287) |
Wer sind die Geschäftsführer von MODUS GREGORY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, John Elwyn | Sekretär | 2 Hollowgate Swinton M27 0AD Manchester Lancashire | British | 84729210001 | ||||||
FLOOD, Brendan | Geschäftsführer | Mowbray Leigh Road Worsley M28 2QU Manchester | England | British | Property Developer | 38787790002 | ||||
FLOOD, Brendan | Sekretär | 40 Cavendish Road Ellesmere Park Eccles M30 9JF Manchester | British | Property Developer | 38787790001 | |||||
GREGORY, George Barry | Sekretär | The Cottage Stainburn Lane Leathley LS21 2LF Otley North Yorkshire | British | Company Director | 29331210001 | |||||
ROBERTSON, Marjorie | Sekretär | 78 Blackmoor Lane Bardsey LS17 9DY Leeds | British | Accountant | 72111170002 | |||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
FLOOD, Damian | Geschäftsführer | 4 New Bank Close Dobcross OL3 5LE Oldham Lancashire | United Kingdom | British | Property Developer | 99422430001 | ||||
GREGORY, George Barry | Geschäftsführer | The Cottage Stainburn Lane Leathley LS21 2LF Otley North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 29331210001 | ||||
MCGAWLEY, Richard Thomas | Geschäftsführer | 6 Robert Moffat High Legh WA16 6PS Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 70917180001 | ||||
RIDDELL, James Michael Charles | Geschäftsführer | Brook Road WA13 9AH Lymm 2 Cheshire | England | British | Property Manager | 60942110002 | ||||
WILKINSON, Peter John Byrne | Geschäftsführer | 2 Haworth Grove Heaton BD9 5PE Bradford West Yorkshire | British | Company Director | 9269380001 | |||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Hat MODUS GREGORY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge (third party) | Erstellt am 04. Dez. 2008 Geliefert am 19. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from modus properties limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the north side of high street west, on the east side of glossop brook road, on the north west side of wrens west road and on the west side of shrewsbury street, glossop t/no DY205877 by way of fixed charge the goodwill.by way of floating charge all plant machinery equipment furniture and other chattel assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Charge of building contract | Erstellt am 12. Jan. 2005 Geliefert am 18. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns the right title and interest in and to a building contract dated 17 november 2004 and a performance bond dated 16 december 2004 and all money pursuant to the agreements and all contracts present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of agreements | Erstellt am 18. Aug. 2004 Geliefert am 21. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The agreements and other documents granted in relation to the f/h and l/h land and premises at wren nest retail park glossop derbyshire and all money pursuant to the agreement. The agreements being 1. an agreement for lease underlease and sale dated 30 april 2004 made between (1) modus gregory limited (2) oakapple homes (glossop) limited (3) oakapple estates limited and (4) modus properties limited and gregory property holdings limited 2. an escrow deed dated 18 august 2004 made between (1) modus gregory limited (2) oakapple homes (glossop) limited (3) barclays bank limited 3. a legal charge over land adjacent to the property dated 18 august 2004 made between (1) oakapple homes (glossop) limited and (2) modus gregory limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of agreement for lease | Erstellt am 18. Aug. 2004 Geliefert am 21. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The agreements and other documents for the grant of a lease or leases of property k/a the f/h and l/h land and premises at wren nest retail park glossop derbyshire and all money due pursuant to the agreement. The agreements being 1. agreement for lease relating to unit a dated 1 august 2003 between (1) the company and (2) focus (diy) limited 2. agreement for lease relating to unit b dated 4 june 2004 between (1) the company and (2) next group PLC. For details of further agreements charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 2004 Geliefert am 21. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h land and premises to be known as wren nest retail park glossop derbyshire. For further details of the property charged please refer to form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2004 Geliefert am 21. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat MODUS GREGORY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0