MILK LINK MLS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMILK LINK MLS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04427839
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MILK LINK MLS LIMITED?

    • (7012) /

    Wo befindet sich MILK LINK MLS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3120 Great Western Court
    Hunts Ground Road
    BS34 8HP Stoke Gifford
    Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MILK LINK MLS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MILK LINK (STAPLEMEAD) LIMITED05. Juni 200205. Juni 2002
    QUAYSHELFCO 924 LIMITED30. Apr. 200230. Apr. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MILK LINK MLS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Apr. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für MILK LINK MLS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 03. Apr. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 04. Apr. 2009

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed milk link (staplemead) LIMITED\certificate issued on 29/09/08
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    3 Seiten403b

    legacy

    3 Seiten403b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von MILK LINK MLS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    YOUNG, Karen Bridget
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    Sekretär
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    British94953930001
    WILLIAMS, David Anthony James
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Geschäftsführer
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    EnglandBritishCompany Director57267910003
    YOUNG, Karen Bridget
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    Geschäftsführer
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    EnglandBritishCompany Secretary94953930001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Bevollmächtigter Sekretär
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    GLEN, Nairn
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    EnglandBritishNon Executive Director83521290001
    NICHOLLS, Barry
    Freshford House
    Churchill Freshford
    BA2 7TX Bath
    Geschäftsführer
    Freshford House
    Churchill Freshford
    BA2 7TX Bath
    BritishDirector71018890003
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    Hat MILK LINK MLS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Erstellt am 20. Feb. 2006
    Geliefert am 23. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 2006
    Geliefert am 23. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land being staplemead creamery, lullington lane, staplemead, frome, somerset t/no WS17821 and l/h land being land forming part of staplemead creamery, lullington lane, staplemead, frome, somerset t/no WS17973 and all buildings, fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such property together with all rights, easements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    All assets debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2006
    Geliefert am 23. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2006
    Geliefert am 23. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 20. Feb. 2004
    Geliefert am 09. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The original security agreement shall be amended as per details on the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Trading as Rabobank International) (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 09. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as church lane crediton, leasehold property known as staplemead creamery staplemead and freehold property known as oxford lane dairy sible hedingham halstead essex t/n EX630848 (for further details of property charged see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffesen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International London Branch) Asagent and Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0