ELM PROPERTY FINANCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELM PROPERTY FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04428980 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Quantuma Llp High Holborn House 52-54 High Holborn WC1V 6RL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ACACIA PROPERTY FINANCE LIMITED | 01. Mai 2002 | 01. Mai 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 58 Acacia Road London NW8 6AG zum C/O Quantuma Llp High Holborn House 52-54 High Holborn London WC1V 6RL am 10. Sept. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von International Registrars Limited als Sekretär am 05. Mai 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2018 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Elio Astone am 14. Nov. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2017 bis 27. Feb. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2016 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Elio Astone als Direktor am 23. Mai 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ronald Natas als Geschäftsführer am 23. Mai 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Robert Anderson als Geschäftsführer am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Michael Alexander als Geschäftsführer am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2015 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Finsgate 5-7 Cranwood Street London EC1V 9EE* am 10. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTONE, Elio | Geschäftsführer | Acacia Road NW8 6AG London 58 United Kingdom | United Kingdom | Italian | Director | 208758500001 | ||||
| BROWN, Lawrence Barry | Sekretär | Hall Studio 23b Grove End Road NW8 9BO London | British | 89879990001 | ||||||
| DENCH, Kevin John | Sekretär | 11 Otterham Quay Lane ME8 8LL Rainham Kent | British | 105554850001 | ||||||
| HIORNS, Trevor John | Sekretär | 12 Ashwell Road Bygrave SG7 5DT Baldock Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 19855280001 | |||||
| SANDERSON, Anthony Hurst | Sekretär | 70 St Andrews Road RG9 1JE Henley On Thames Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 10422510002 | |||||
| INTERNATIONAL REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Cranwood Street, EC1V 9EE London Finsgate, 5-7 United Kingdom | 130414050001 | |||||||
| SDG SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900023580001 | |||||||
| ALEXANDER, Nigel Michael | Geschäftsführer | Bucks Close Village Road MK43 8HG Bromham 2 Bedfordshire | England | British | Director | 162208010001 | ||||
| ANDERSON, Matthew James Robert | Geschäftsführer | 56 Alexandra Drive KT5 9AF Surbiton Surrey | England | English | Property Professional | 117920400001 | ||||
| BRANSKY, Sandra | Geschäftsführer | 25 Basel Street Herzliya Pituach 46660 Isreal | South Africa | Director | 83190250001 | |||||
| BROWN, Dennis Hugh | Geschäftsführer | Hall Studio 23b Grove End Road NW8 9BO London | British | Shipper | 75099270001 | |||||
| BROWN, Lawrence Barry | Geschäftsführer | 4 Wadham Gardens NW3 3DP London | United Kingdom | British | Financier | 89879990002 | ||||
| FREED, Neville Hannan, Dr | Geschäftsführer | Flat 8 14 Lindfield Gardens NW3 6PU London | United Kingdom | British | Financial Administrator | 3981650002 | ||||
| HIORNS, Trevor John | Geschäftsführer | 12 Ashwell Road Bygrave SG7 5DT Baldock Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 19855280001 | |||||
| NATAS, Ronald | Geschäftsführer | 48 Circus Road NW8 9SE London | United Kingdom | South African | Director | 71581140002 | ||||
| SDG REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900023570001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELM PROPERTY FINANCE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance And Credit Corporation Limited | 06. Apr. 2016 | 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London Finsgate United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ELM PROPERTY FINANCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Sub-mortgage | Erstellt am 02. Aug. 2012 Geliefert am 08. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £5,400,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A sub-mortgage dated 2 august 2012. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed security agreement and assignment | Erstellt am 06. März 2007 Geliefert am 20. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged account numbered 01994212 sort code 238482 and account reference elm property finance limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Nov. 2006 Geliefert am 24. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at timber yard lane lewes east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed security agreement and assignment | Erstellt am 10. Nov. 2006 Geliefert am 17. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged account numbered 01994055 sort code 238482,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating security agreement | Erstellt am 10. Nov. 2006 Geliefert am 17. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge over undertaking assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Jan. 2006 Geliefert am 20. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed security agreement and assignment | Erstellt am 21. Nov. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company, with full title guarantee and security for the payment of all liabi, charges the account being: account number 01994055, sort code 238482, and account reference elm property finance limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Nov. 2005 Geliefert am 23. Nov. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Aug. 2003 Geliefert am 14. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 2002 Geliefert am 14. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0