TULA GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTULA GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04433635
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TULA GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TULA GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o EY
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TULA GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPEED 9165 LIMITED08. Mai 200208. Mai 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TULA GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für TULA GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Jayne Mary Worden als Geschäftsführer am 11. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Jan. 2019

    10 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Radley, 3rd Floor Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW zum C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF am 21. Feb. 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Jan. 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 26. Jan. 2018

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 25/01/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    15 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Roger Clive Best als Geschäftsführer am 03. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gregory Pratt als Sekretär am 03. Juni 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Naomi Halliday als Geschäftsführer am 03. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas James Vance als Geschäftsführer am 03. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 264,250
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    10 SeitenAA

    Ernennung von Mr Justin Paul David Stead als Direktor am 07. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Xavier Marie Olivier Simonet als Geschäftsführer am 08. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    AA

    Wer sind die Geschäftsführer von TULA GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STEAD, Justin Paul David
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Sekretär
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    PRATT, Gregory
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Sekretär
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167192940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Geschäftsführer
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Geschäftsführer
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    CORLETT, Anthony John Darcy
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    42 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    United KingdomBritish37929030005
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Geschäftsführer
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HALLIDAY, Naomi
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    United KingdomBritish184787710001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Geschäftsführer
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    LISTER, Ivan James
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    Geschäftsführer
    14 Elmore Street
    N1 3AL London
    United KingdomBritish67150960004
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Geschäftsführer
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    VANCE, Nicholas James
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Radley, 3rd Floor
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish184753710001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Geschäftsführer
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    c/o Ey
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish109333140001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TULA GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06. Apr. 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer5707910
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat TULA GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 09. Dez. 2007
    Geliefert am 18. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 1 site b brundell drive brinklow mi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 12. Juli 2006
    Geliefert am 01. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 10. Juli 2006
    Geliefert am 14. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re tula group LTD and numbered 2061452 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respectthereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2006
    Geliefert am 09. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 1, site b, brundell drive, brinklow, milton keynes t/n BM296212. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 09. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 11. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 11. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lowell Judith Harder
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TULA GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Jan. 2018Beginn der Liquidation
    12. Feb. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praktiker
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praktiker
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0