PROFIVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROFIVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04433872
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROFIVE LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich PROFIVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    53 53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROFIVE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ONYXTOWER LIMITED08. Mai 200208. Mai 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROFIVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROFIVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Apr. 2019

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Apr. 2018

    12 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 12. Apr. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE England zum 53 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE am 10. März 2017

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Sannerville Chase Exminster Exeter Devon EX6 8AT zum 53 Fore Street Ivybridge Devon PL21 9AE am 09. März 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gerald John Tranckle am 08. Aug. 2016

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 044338720013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. März 2016

    Kapitalaufstellung am 29. März 2016

    • Kapital: GBP 300
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 044338720013, erstellt am 21. Juli 2015

    8 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. März 2015

    Kapitalaufstellung am 25. März 2015

    • Kapital: GBP 300
    SH01

    Erfüllung der Belastung 044338720012 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. März 2014

    Kapitalaufstellung am 25. März 2014

    • Kapital: GBP 300
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    11 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 044338720012

    10 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von PROFIVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KNIGHT, Adrian Timothy
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    Sekretär
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    BritishChartered Accountant73020680001
    JOHNSON, David Robin
    Heather Banks
    The Vineyard
    TQ9 6HW Dartington
    Devon
    Geschäftsführer
    Heather Banks
    The Vineyard
    TQ9 6HW Dartington
    Devon
    United KingdomBritishArchitect100080410001
    KNIGHT, Adrian Timothy
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Elmlea
    Taddyforde St Davids
    EX4 4AT Exeter
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant73020680001
    LEE, Philip Robert
    97 Sidford Road
    EX10 9NR Sidmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    97 Sidford Road
    EX10 9NR Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishQuantity Surveyor31827310003
    TRANCKLE, Gerald John
    6 The Coppice
    Dawlish
    Oaklea
    Devon Ex7 0ln
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 The Coppice
    Dawlish
    Oaklea
    Devon Ex7 0ln
    United Kingdom
    EnglandBritishBuilder68972180006
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    CUSA, Peter John
    65 Clyst Valley Road
    Clyst St. Mary
    EX5 1DE Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    65 Clyst Valley Road
    Clyst St. Mary
    EX5 1DE Exeter
    Devon
    United KingdomBritishArchitect126644870001
    WILLOCKS, Sydney George
    Tenggara
    30 Newton Road
    TQ14 9PN Bishopsteignton
    Devon
    Geschäftsführer
    Tenggara
    30 Newton Road
    TQ14 9PN Bishopsteignton
    Devon
    United KingdomBritishEngineer65888730002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PROFIVE LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    25. März 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat PROFIVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. Juli 2015
    Geliefert am 22. Juli 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The owner, as a continuing security for the payment on demand of the owner's obligations and with full title guarantee charges to the bank by way of legal mortgage all legal interest in the property, being land to rear of crooks cross known as raleigh mead, south molton, devon registered at the land registry with title number DN636466 and gives to the bank a fixed charge over any other interest in the property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 24. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Aug. 2013
    Geliefert am 15. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    F/H land as land and buildings lying to the north of cooks cross, south molton, devon t/no DN393761. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2011
    Geliefert am 24. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old post office, old newton road, heathfield, newton abbot t/no DN515089. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £25,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The old post office, old newton road, heathfield, newon abbot t/no DN515089.
    Berechtigte Personen
    • Ravenslade Limited
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 2007
    Geliefert am 25. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old fire station, first avenue, teig. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 2007
    Geliefert am 16. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16/17 charlotte street crediton devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 2005
    Geliefert am 04. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at chittlehampton umberleigh devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ridgeway 71 teignmouth road teignmouth devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 2004
    Geliefert am 29. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 2003
    Geliefert am 29. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £240,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property known as former milber post office 11 pinewood road newton abbot devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £122,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    25 maudlin drive teignmouth devon TQ14 8RZ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 2002
    Geliefert am 30. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £115,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 12 hazeldown road teignmouth devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 26. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £130,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a 5 derncleugh gardens, holcombe, dawlish EX7 0JG. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PROFIVE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Sept. 2020Aufgelöst am
    12. Apr. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samuel Adam Bailey
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Praktiker
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Hamish Millen Adam
    Richard J Smith & Co
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon
    Praktiker
    Richard J Smith & Co
    53 Fore Street
    PL21 9AE Ivybridge
    Devon

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0