GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04436478
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11 Humber Street
    Hull
    HU1 1TG East Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Jan. 2013

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Nov. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Mai 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Nov. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 06. Apr. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 06. Apr. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Nov. 2009

    LRESEX

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MATTHEWS, Katie Louise
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    Sekretär
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    British99750240004
    MATTHEWS, Katie Louise
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    Sekretär
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    British99750240004
    EVANS, David Hugh
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    Geschäftsführer
    Ring Beck House
    Ring Beck Lane
    HU15 2DD Ellerker
    BritishProperty Developer70348800010
    HARRISON, Charles Edward
    21 Oaklands
    Cranswick
    YO25 9RN Driffield
    East Yorkshire
    Sekretär
    21 Oaklands
    Cranswick
    YO25 9RN Driffield
    East Yorkshire
    British9884170002
    LEGAL SECRETARIES LIMITED
    10 Cromwell Place
    South Kensington
    SW7 2JN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Cromwell Place
    South Kensington
    SW7 2JN London
    900022670001
    LEGAL DIRECTORS LTD (COMP NBR 3368733)
    10 Cromwell Place
    South Kensington
    SW7 2JN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 Cromwell Place
    South Kensington
    SW7 2JN London
    900022660001

    Hat GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 2006
    Geliefert am 21. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 spring bank, kingston upon hull t/no HS139017.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 2005
    Geliefert am 21. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    55 kings bench street kingston upon hull t/no HS175505.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 225. Nov. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 202. Juni 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 2005
    Geliefert am 14. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    48 camden street kingston upon hull t/no HS42423.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 2005
    Geliefert am 21. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old barn priestgate nafferton driffield.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    46 kings bench street kingston upon hull t/n HS146340.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    102 plane street kingston upon hull t/n HS294736.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    83A rosmead street kingston upon hull t/n HS182778.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    20 salisbury street kingston upon hull t/n HS268112.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    18 weghill road preston t/n HS264039.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 01. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 st james road bridlington t/n YEA17438.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 125. Nov. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 102. Juni 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 01. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 granville street kingston upon hull t/n HS284538.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 01. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23 chanterlands avenue kingston upon hull t/n HS294578.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    375-377 anlaby road kingston upon hull t/no HS74155.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    105 first lane hessle t/n HS124311.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    53 halland street kingston upon hull t/n HS299933.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    75 st. Johns street bridlington east riding of yorkshire t/n HS6781.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 blackburn avenue bridlington east riding of yorkshire t/n HS101180.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    70 salisbury street kingston upon hull t/n HS180067.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 humber street kingston upon hull t/n HS203468.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 clarence road bridlington t/n HS30879.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    157 southcoates avenue kingston upon hull t/n HS280172.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    154 kirklands road kingston upon hull t/n HS293552.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 st nicholas gardens kingston upon hull t/n HS62297.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9A trinity road bridlington t/n HS70875.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 ashville street bridlington t/n HS68916.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GUARDIAN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Michael Skinner
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Receiver Manager
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Hugh Lawrence Dorins
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Receiver Manager
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Michael Skinner
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Receiver Manager
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Hugh Lawrence Dorins
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    Receiver Manager
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    3
    DatumTyp
    06. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    17. Apr. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Paul Halligan
    City Mills Peel Street
    Morley
    LS27 8QL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    City Mills Peel Street
    Morley
    LS27 8QL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0