HOMEFLAG LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOMEFLAG LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04439855 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOMEFLAG LIMITED?
- Taxibetrieb (49320) / Verkehr und Lagerei
- Sonstiger Personenlandverkehr (49390) / Verkehr und Lagerei
- Lizenziertes Träger (53201) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich HOMEFLAG LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 35-37 William Road NW1 3ER London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HOMEFLAG LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLUEBACK LIMITED | 16. Apr. 2003 | 16. Apr. 2003 |
| VERYNOON LIMITED | 15. Mai 2002 | 15. Mai 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOMEFLAG LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOMEFLAG LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David George Stickland als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Kenneth Boland als Sekretär am 04. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Lee Gage als Sekretär am 04. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Andrew Kenneth Boland als Sekretär am 24. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Cust als Sekretär am 24. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Cust als Geschäftsführer am 24. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Chief Financial Officer Andrew Kenneth Boland als Direktor am 03. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Gary Cust als Direktor am 28. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Barbrook als Geschäftsführer am 28. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Barbrook als Sekretär am 25. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Gary Cust als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 2 Seiten | SH10 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 29 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Liam Griffin am 17. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOMEFLAG LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE, Lee | Sekretär | 9 Boyd Street E1 1NH London Flat 9 Victoria Mills United Kingdom | 207449740001 | |||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Geschäftsführer | William Road NW1 3ER London 35-37 England England | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| GRIFFIN, Liam | Geschäftsführer | William Road NW1 3ER London 35-37 England | England | British | 146320180001 | |||||
| STICKLAND, David George | Geschäftsführer | William Road NW1 3ER London 35-37 United Kingdom | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||
| BARBROOK, Matthew James | Sekretär | William Road NW1 3ER London 35-37 England | British | 79274880001 | ||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Sekretär | William Road NW1 3ER London 35-37 England England | 200421510001 | |||||||
| CUST, Gary | Sekretär | William Road NW1 3ER London 35-37 England | 187183860001 | |||||||
| FOSTER, Daryl | Sekretär | Yoo Building 17 Hall Road NW8 9RF London Flat 45 | British | 43291390002 | ||||||
| KERR, Darren Mark, Mr. | Sekretär | Christchurch Crescent WD7 8AU Radlett 20a Hertfordshire | British | 140334370001 | ||||||
| PIELSTICKER, Charles Albert | Sekretär | 18 Hillhurst Blvd M4R 1K4 Toronto Ontario Canada | British | 82639410001 | ||||||
| PIELSTICKER, Scott William | Sekretär | Flat 2 39 St Luke`S Road W11 1DD London | Canadian | 82639190003 | ||||||
| THOMAS, Howard | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||
| DORSEYLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 21 Wilson Street EC2M 2TD London | 74615640001 | |||||||
| BAILLIE, Aubrey | Geschäftsführer | 90 St. Leonards Ave. Toronto Ontario M4n 1k5 | Canadian | 109409880001 | ||||||
| BANKS, Joseph Robert | Geschäftsführer | 2 Albert Place W8 5PD London | United Kingdom | American | 97950200001 | |||||
| BARBROOK, Matthew James | Geschäftsführer | William Road NW1 3ER London 35-37 England | United Kingdom | British | 79274880001 | |||||
| BUTCHER, Nicholas Terence | Geschäftsführer | Moorcroft Abinger Lane Abinger Common RH5 6HZ Dorking Surrey | England | British | 18037300001 | |||||
| CUST, Gary William | Geschäftsführer | William Road NW1 3ER London 35-37 | England | British | 193071220001 | |||||
| DARLING, Peter John | Geschäftsführer | Chandlers House Fenwick Place SW9 9NW London | British | 91106210001 | ||||||
| FOSTER, Daryl | Geschäftsführer | Yoo Building 17 Hall Road NW8 9RF London Flat 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 43291390003 | |||||
| GRIFFIN, John Patrick | Geschäftsführer | 23 The Avenue EN6 1EG Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British,Irish | 43291450001 | |||||
| GRIFFIN, Kieran | Geschäftsführer | Bedwell Park, Cucumber Lane Essendon AL9 6GJ Hatfield Pulham House Hertfordshire | United Kingdom | British | 82674390003 | |||||
| JOHNSON, Donald Kenneth | Geschäftsführer | 287 Oriole Parkway MSP 2H4 Toronto Ontario Ms9 2h4 Canada | Canadian | 109607400001 | ||||||
| KENNEDY, Andrew James | Geschäftsführer | 2 Edgarley Terrace SW6 6QF London | United Kingdom | Canadian | 101185570001 | |||||
| L'HEUREUX, Willard John | Geschäftsführer | Eotvos U 47 FOREIGN Budapest 1067 Hungary | Canadian | 91989750001 | ||||||
| PEARCE, Colin Leighton | Geschäftsführer | Lamorna 38 Denham Lane SL9 0ET Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 169666820001 | |||||
| PIELSTICKER, Scott William | Geschäftsführer | Flat 2 39 St Luke`S Road W11 1DD London | Canadian | 82639190003 | ||||||
| SCHWARZ, Steve | Geschäftsführer | 12 Measham Road LE65 2PF Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 109410140001 | |||||
| TESTER, William Andrew Joseph | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | 900000890001 | |||||
| HELKON SK LIMITED | Geschäftsführer | 74a Charlotte Street W1T 4QJ London | 91989880001 |
Hat HOMEFLAG LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture without written instrument | Erstellt am 02. Mai 2007 Geliefert am 22. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £300,000.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben All company assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 2007 Geliefert am 07. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £300,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over all assets of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 29. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juni 2006 Geliefert am 26. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £500,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed charge over the chattels and equipment, book debts, goodwill and uncalled capital and floating charge, all the undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture without written instrument | Erstellt am 23. Nov. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,542,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture without written instrument | Erstellt am 22. Nov. 2005 Geliefert am 02. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £40,000 and us$80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating over all the assets of the company (including, for the avoidance of doubt, book debts). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 29. Juni 2004 Geliefert am 05. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 2003 Geliefert am 19. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0