EIFFEL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEIFFEL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04440353
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EIFFEL LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei
    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich EIFFEL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EIFFEL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für EIFFEL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lethbridge Fowler am 20. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG zum 15 Canada Square London E14 5GL am 23. Okt. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Sept. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Lindsay Ginnette Sides als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Donald Cook als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Stuart Donald Cook am 26. Aug. 2016

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mrs. Lindsay Ginnette Sides als Direktor am 12. Aug. 2016

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von EIFFEL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine ("Kasia") Marie Madeleine, Ms.
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    British129779700001
    DENT, Nicholas Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish135237620002
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Sekretär
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    British95892040001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Sekretär
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Bevollmächtigter Sekretär
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    BISHOP, Julian Kenneth, Mr.
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish20351210002
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOther95892040003
    COOK, Stuart Donald
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United KingdomBritish191477240004
    COXON, David
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish121539300001
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Australian49828980005
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritish72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritish83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritish99475270002
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish212141970001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    British72665990003
    WILLIAMS, Gareth, Mr.
    Sg House
    41, Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sg House
    41, Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    United KingdomBritish120326750001
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EIFFEL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sg Leasing (March) Limited
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales (Companies Act 2006)
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer00775046
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat EIFFEL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First priority bahamian statutory ship mortgage
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel official number 8000530 together with boats guns ammunition. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cma Cgm (UK) Shipping Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel official number 8000530 together with all her engines machinery boats. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cma Cgm (UK) Shipping Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Lessor assignment and charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the hull and war insurances the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cma Cgm (UK) Shipping Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A third priority deed of assignment
    Erstellt am 13. Nov. 2002
    Geliefert am 29. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the sponsor to the chargee (the assignee) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest present and future of the company in, to and under the insurances, including all payments to the company in respect thereof and all claims, rights and remedies of the company arising therefrom (including all damages and compensation payable for or in respect thereof). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merit Shipowning S.A.L. Offshore
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority bahamas ship mortgage
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the vessel under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000530. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedship Bank N.V.
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to the vessel under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000530. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedship Bank N.V.
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A bahamian mortgage
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 30. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The ship named M.V. "cma cgm eiffel" with official number 8000 530 registered at the bahamas maritime authority and in her equipment and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Equipment Leasing (No.3) Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment of shipbuilding contract and refund guarantee
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to the chargee and/or any of the credit participants
    Kurze Angaben
    The right title and legal and beneficial interest in and to and all benefits accruing to the assignor under or pursuant to the building contract and the refund guarantee including all the assignors rights in and to the vessel as she is constructed the right to take delivery of the vessel all sums payable or which may become payable to or to the order of the assignor under or pursuant to the building contract or the refund guarantee and all damages and other payments.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedship Bank N.V. (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the secured parties to the chargee and/or any of the beneficiaries
    Kurze Angaben
    The whole of the companys undertakings property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including any uncalled capital and the proceeds of any future call. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedship Bank N.V. (Acting as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of general assignment
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to the chargee and/or any of the credit participants under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to the assigned property and charges by way of first fixed charge the account balances as security for the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nedship Bank N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A second priority deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 30. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest present and future in and to all policies and contracts of insurance and/or reinsurance which are from time to time in place or taken out, any compensation payable in respect of the compulsory acquistion or requisition for the title of the vessel.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Equipment Leasing (No.3) Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat EIFFEL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Dez. 2018Aufgelöst am
    27. Sept. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0