LAWGRA (NO.947) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLAWGRA (NO.947) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04444712
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LAWGRA (NO.947) LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich LAWGRA (NO.947) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Hockley Court
    Stratford Road, Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAWGRA (NO.947) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für LAWGRA (NO.947) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    11 Seiten395

    legacy

    12 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2003

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von LAWGRA (NO.947) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURNETT, Stephen Andrew
    Hunters Lodge
    Station Road
    CV35 8PE Claverdon
    Warwickshire
    Sekretär
    Hunters Lodge
    Station Road
    CV35 8PE Claverdon
    Warwickshire
    British66395320004
    GALLAGHER, Anthony Christopher, Sir
    Sarsden House
    Sarsden
    OX7 6PW Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Sarsden House
    Sarsden
    OX7 6PW Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish86375800002
    GOSLING, Geoffrey Hugh
    Bumble End Woodside Drive
    Little Aston
    B74 3BB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bumble End Woodside Drive
    Little Aston
    B74 3BB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish78796680001
    MANIN, Richard Raymond Emile
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Sekretär
    236 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    British29741390003
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Bevollmächtigter Sekretär
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    CARTISSER, Matthew Grant
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    Geschäftsführer
    Leighton Manor Farm
    Spode Lane
    TN8 7HN Cowden
    Kent
    United KingdomBritish82316750001
    EASTWOOD, Simon Paul
    Rosegarth Temple Way
    SL2 3HE Farnham Common
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Rosegarth Temple Way
    SL2 3HE Farnham Common
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish35184590004
    MORGAN, Simon Bruce
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Netherhope House
    Netherhope Lane
    NP16 7JG Tidenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish86142950001
    RICHARDSON, Donald Barrie
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    Geschäftsführer
    100 Dudley Road East
    B69 3DY Oldbury
    West Midlands
    British44851070002
    WHALE ROCK DIRECTORS LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900019450001

    Hat LAWGRA (NO.947) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2006
    Geliefert am 10. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from islandview properties limited to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a the gallagher retail park hambeldon road waterlooville hampshire t/no SH9562 any present and future insurance in respect of the property and the proceeds of such insurances,the rent. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Agent and Security Trustee for Thebeneficiaries
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2006
    Geliefert am 10. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from islandview properties limited to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Agent and Security Trustee for Thebeneficiaries
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings k/a wellington retail park hambledon road waterlooville t/n SH9562. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0