BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04448005
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELITEDEGREE LIMITED27. Mai 200227. Mai 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Feb. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Apr. 2016

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    19 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2016

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Aug. 2015

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2015

    18 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2015

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2015

    18 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Aug. 2014

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2014

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Sept. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Apr. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Beendigung der Bestellung von Benjamin Broader als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Vorschlag des Verwalters

    52 Seiten2.17B

    legacy

    53 SeitenMG06

    Wer sind die Geschäftsführer von BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ACCOMPLISH SECRETARIES LIMITED
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Sekretär
    South Street
    Mayfair
    W1K 1DG London
    18
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5752036
    121109170001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    BritishBanker70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Sekretär
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    British64264570001
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    BritishInvestment Director82500670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Sekretär
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    BritishBanker62111350002
    BROADER, Benjamin
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IsraelBritishChartered Accountant165999470001
    CLARKE, Jonathan George Gough
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    Geschäftsführer
    Westland Farm
    Ockley Road
    GU6 7SL Ewhurst
    Surrey
    BritishDirector72712910001
    GILBERT, Paul John Thomas
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Oldfield
    St Mary's Road
    WA14 2PJ Bowden
    Cheshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant149769990001
    GODDARD, James Michael
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    131 Beeleigh Link
    CM2 6PH Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishBanker70168860001
    HANSON, Tracey Anna Marie
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    Geschäftsführer
    4 Broomsleigh Street
    NW6 1QW London
    BritishDirector64264570001
    MACNAUGHTON, Robert Magnus
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    Geschäftsführer
    High Tong Lodge
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    Kent
    BritishDirector66538980003
    MACRAE, Gregor Charles William
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant151235850002
    MURPHY, Dominic Patrick
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Cobden Field
    12 Cobden Hill
    WD7 7LN Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Director82500670001
    MURRAY, Sean Anthony
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector67091270001
    ROBINSON, Philip Thomas
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    11 Kennedy Close
    BR5 1HP Orpington
    Kent
    BritishDirector72559430001
    RUDGE, David
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Street
    W1K 1DG London
    18
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector58543980004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    ULTRALINK LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Geschäftsführer
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023330001
    WISEBET LIMITED
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    Geschäftsführer
    2nd Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    94023340001

    Hat BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental third party security
    Erstellt am 11. Juli 2008
    Geliefert am 17. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Specialised Property Investments Limited (Formerly Rbs Hotel Investments (No.2) Limited)
    Transaktionen
    • 17. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 11. Juli 2008
    Geliefert am 17. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 11. Juli 2008
    Geliefert am 17. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, senior beneficiaries and stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sheffield arundel gate the land more particularly described in a supplemental lease between cordwell (pond street) limited (1) and bishopsgate parking (no.2) limited (2) dated 11 july 2008 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 16. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the senior beneficiaries, the stretch senior beneficiaries, the mezzanine beneficiaries, the hillstep senior beneficiaries the hillstep stretch senior beneficiaries and the hillstep mezzanine beneficiaries on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    No. 2 aldersgate lh t/no. NGL705135: no. 8 berners st lh t/no. LN192051 and LN191912: no. 12 birmingham horsefair fh t/no. WM427086 please see form for further details of property charged. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transaktionen
    • 16. März 2005
    Third party security
    Erstellt am 17. Nov. 2003
    Geliefert am 05. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from powerfocal to the beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a no 2 aldersgate, t/n NGL705135, the l/h property k/a no 8 berners st, t/ns LB192051 and LN191912, the f/h property k/a no 12 birmingham horsefair, t/n WM427086, see schedule attached to form 395 for other properties charged, the interest in the sale agreements, the occupational leases, the licences, the managing agent's agreement, the head leases, the tax deeds and all agreements in which BPL2 has an interest;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments (No.2) Limited (the Beneficiary)
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 2003
    Geliefert am 05. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the mezzanine beneficiaries, the stretch senior beneficiaries and the senior beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Non-recourse legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Non-recourse legal charge by trustees
    Erstellt am 17. Nov. 2003
    Geliefert am 02. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land known as the two storey underground car park beneath part of the north garden cadogan place chelsea london SW1X 9SA and the land below the car park together with the roof the access ramp and the fire escape staircases the ventilation extract and its housing and the smoke extracts above the roof of the car park. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Hotel Investments (No. 2) Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Lightweight floating charge
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due rom the obligors to the mezzanine beneficiaries and the stretch senior beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the assets property and undertaking of the chargor both present and future including all its goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BISHOPSGATE PARKING (NO.2) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Apr. 2016Ende der Verwaltung
    19. Okt. 2012Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    09. März 2016Antragsdatum
    22. Nov. 2016Abschluss der Liquidation
    11. Apr. 2016Beginn der Liquidation
    05. März 2017Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0