DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04457527
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Feb. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Notification of Development Securities (Investments) Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Feb. 2016

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Charles Julian Barwick als Geschäftsführer am 07. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Michael Henry Marx als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard Upton als Direktor am 08. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Charles Julian Barwick am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Henry Marx am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew Simon Weiner am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Marcus Owen Shepherd am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Chris Barton am 09. Nov. 2015

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2015

    3 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS zum 7a Howick Place London SW1P 1DZ am 11. Nov. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Ernennung von Mr Chris Barton als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Marcus Owen Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2014

    3 SeitenAA

    Ernennung von Mr Marcus Owen Shepherd als Sekretär am 01. Sept. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Helen Maria Ratsey als Sekretär am 01. Sept. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Julian Barwick am 15. Apr. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Sekretär
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193873910001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish41925000005
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Sekretär
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158458340001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659860001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BARWICK, Charles Julian
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish3818640003
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    PROTHERO, Graham
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish134427450001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00701787
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat DEVELOPMENT SECURITIES (NO. 11) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 2011
    Geliefert am 22. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and property k/a 131 broadway bexleyheath t/no. SGL519434 by way of fixed charge all rights and interest in the rental income goodwill and the proceeds of insurances by way of floating charge all right and interest in all plant and equipment located in the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 16. Dez. 2011
    Geliefert am 22. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 131 broadway, bexleyheath t/no SGL519434. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2005
    Geliefert am 17. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from development securities PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of f/h property k/a 131 the broadway bexleyheath kent t/no SGL519434.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 23 december 1998)
    Erstellt am 11. Juli 2005
    Geliefert am 29. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from development securities estates PLC and development securities (strategic) LTD to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 131 the broadway bexleyheath kent t/n SGL519434 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of release and charge
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Erworben am 08. Apr. 2003
    Geliefert am 17. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,000,000 11% first mortgage debenture stock 2016 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    131 broadway bexleyheath t/n SGL519434 held jointly with development securities (no.7) limited.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 24. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0