EVER 1824 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEVER 1824 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04460079
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EVER 1824 LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich EVER 1824 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVER 1824 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für EVER 1824 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. März 2017

    8 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor Clarence House Clarence Street Manchester M2 4DW zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 14. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 23. März 2016

    LRESSP

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 16. Juni 2015

    • Kapital: GBP 4
    SH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    DISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    14 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Juni 2014

    • Kapital: GBP 4
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Simon Bate als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Pinnacle 5Th Floor 73 - 79 King Street Manchester M2 4NG England* am 27. Juni 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kenneth Knott als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Parker als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David Burkinshaw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Burke als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Old School House George Leigh Street Manchester M4 6AF* am 08. Dez. 2011

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von EVER 1824 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Sekretär
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    British145992930001
    CROSS, Jonathan Paul
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Low Meadow
    SK23 7AY Whaley Bridge
    22
    Derbyshire
    United KingdomBritish145991240001
    HUGHES, John James
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    Geschäftsführer
    2 Bamford Road
    M20 2GW Didsbury
    Ivy Bank
    EnglandBritish125765810001
    BATE, Simon Donald
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    Sekretär
    24 Park Road
    WA15 9NN Altrincham
    British75874130004
    COUGHLAN, Monica
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    Sekretär
    Newlands
    Station Road
    SK6 6PA Marple
    Cheshire
    British106801230001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    ARMSTEAD, Michael Brian
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    West House Fiveways
    1 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish57228500002
    BATE, Simon Donald
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 East Downs Road
    WA14 2LQ Bowdon
    Paddock House
    Cheshire
    United KingdomBritish140715780001
    BURKE, Alan Francis
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    2
    Cheshire
    EnglandBritish182234260001
    BURKINSHAW, David
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    Geschäftsführer
    Carlton Road
    Urmston
    M41 9GY Manchester
    12
    EnglandBritish149306770001
    DODD, Andrew Gerard
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    Geschäftsführer
    Court Essington
    Midford
    BA2 7BX Bath
    United KingdomBritish74768570020
    HENDERSON, Alexander Scott
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Lilacs
    29 Bower Road Hale
    WA15 9DR Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish115112930001
    KNOTT, Kenneth John
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Etherow Country Park
    Compstall
    SK6 5JQ Stockport
    Foxes Lair
    Cheshire
    United KingdomBritish101368570002
    PARKER, Andrew
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Nunnery Way
    Clifford
    LS23 6SL Wetherby
    12
    West Yorkshire
    UkBritish146469710001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Hat EVER 1824 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 21. Okt. 2009
    Geliefert am 09. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor and each other member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings at leopold street sheffield and hotel at leopold street sheffield t/nos syk 508127 and syk 508128. l/h 4A leopold square t/n syk 536745. l/h the old school house, george leigh street, manchester and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 29. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The land and buildings k/a the multi screen cinema and public house clippers quay salford l/h t/no GM824520, the land and buildings k/a the land on the west side of trafford road clippers quay salford l/h t/no GM744333, the land and buildings k/a the pump house trafford road salford l/h t/no GM588084. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Co-Operative Bank P.L.C. as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land on the south west side og clipper quay trafford road t/n GM474905. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2003
    Geliefert am 11. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 2003
    Geliefert am 11. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a multi-screen cinema and public house at clippers quay salford quays t/n gm 824520. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EVER 1824 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. März 2016Beginn der Liquidation
    31. Aug. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0