EVER 1824 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EVER 1824 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04460079 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EVER 1824 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich EVER 1824 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVER 1824 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EVER 1824 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. März 2017 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor Clarence House Clarence Street Manchester M2 4DW zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 14. Apr. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | DISS40 | |||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Bate als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Pinnacle 5Th Floor 73 - 79 King Street Manchester M2 4NG England* am 27. Juni 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kenneth Knott als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Parker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Burkinshaw als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Burke als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Old School House George Leigh Street Manchester M4 6AF* am 08. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EVER 1824 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS, Jonathan Paul | Sekretär | Low Meadow SK23 7AY Whaley Bridge 22 Derbyshire | British | 145992930001 | ||||||
| CROSS, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Low Meadow SK23 7AY Whaley Bridge 22 Derbyshire | United Kingdom | British | 145991240001 | |||||
| HUGHES, John James | Geschäftsführer | 2 Bamford Road M20 2GW Didsbury Ivy Bank | England | British | 125765810001 | |||||
| BATE, Simon Donald | Sekretär | 24 Park Road WA15 9NN Altrincham | British | 75874130004 | ||||||
| COUGHLAN, Monica | Sekretär | Newlands Station Road SK6 6PA Marple Cheshire | British | 106801230001 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
| ARMSTEAD, Michael Brian | Geschäftsführer | West House Fiveways 1 Gorsey Lane WA14 4BN Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 57228500002 | |||||
| BATE, Simon Donald | Geschäftsführer | 20 East Downs Road WA14 2LQ Bowdon Paddock House Cheshire | United Kingdom | British | 140715780001 | |||||
| BURKE, Alan Francis | Geschäftsführer | Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport 2 Cheshire | England | British | 182234260001 | |||||
| BURKINSHAW, David | Geschäftsführer | Carlton Road Urmston M41 9GY Manchester 12 | England | British | 149306770001 | |||||
| DODD, Andrew Gerard | Geschäftsführer | Court Essington Midford BA2 7BX Bath | United Kingdom | British | 74768570020 | |||||
| HENDERSON, Alexander Scott | Geschäftsführer | The Lilacs 29 Bower Road Hale WA15 9DR Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 115112930001 | |||||
| KNOTT, Kenneth John | Geschäftsführer | Etherow Country Park Compstall SK6 5JQ Stockport Foxes Lair Cheshire | United Kingdom | British | 101368570002 | |||||
| PARKER, Andrew | Geschäftsführer | Nunnery Way Clifford LS23 6SL Wetherby 12 West Yorkshire | Uk | British | 146469710001 | |||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Hat EVER 1824 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Okt. 2009 Geliefert am 09. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor and each other member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land and buildings at leopold street sheffield and hotel at leopold street sheffield t/nos syk 508127 and syk 508128. l/h 4A leopold square t/n syk 536745. l/h the old school house, george leigh street, manchester and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The land and buildings k/a the multi screen cinema and public house clippers quay salford l/h t/no GM824520, the land and buildings k/a the land on the west side of trafford road clippers quay salford l/h t/no GM744333, the land and buildings k/a the pump house trafford road salford l/h t/no GM588084. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juni 2003 Geliefert am 02. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land on the south west side og clipper quay trafford road t/n GM474905. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Feb. 2003 Geliefert am 11. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 2003 Geliefert am 11. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a multi-screen cinema and public house at clippers quay salford quays t/n gm 824520. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EVER 1824 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0