PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04465903 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Vine Street W1J 0AH London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HERON STOKE INVESTMENTS (NO.4) LIMITED | 20. Juni 2002 | 20. Juni 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 5 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John George Royds als Geschäftsführer am 08. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert John Hugo Randall am 01. Jan. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John George Royds am 01. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John George Royds am 01. Jan. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Matrix Registrars Limited am 01. Jan. 2011 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Blake am 01. Jan. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hany Tirta als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 7 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John George Royds am 22. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Hanny Tirta am 08. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2010 bis 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Hanny Tirta am 06. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Vine Street W1J 0AH London One England |
| 101009980002 | ||||||||||
| BLAKE, Ian David | Geschäftsführer | Vine Street W1J 0AH London One United Kingdom | England | British | 91275400001 | |||||||||
| RANDALL, Robert John Hugo | Geschäftsführer | Vine Street W1J 0AH London One United Kingdom | United Kingdom | British | 20859810002 | |||||||||
| BRITTAIN, Robert Anthony | Sekretär | 51 Narcissus Road West Hampstead NW6 1TL London | British | 31753460002 | ||||||||||
| TIRTA, Hany | Sekretär | Vine Street W1J 0AH London One United Kingdom | British | 142151860001 | ||||||||||
| ZELTSER, Lionel Harvey | Sekretär | 59 Michleham Down Woodside Park N12 7JJ London | British | 82318190001 | ||||||||||
| MATRIX SECURITIES LIMITED | Sekretär | Gossard House 7-8 Savile Row W1S 3PE London | 60697420001 | |||||||||||
| SDG SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900023580001 | |||||||||||
| GOLDMAN, Alan Irving | Geschäftsführer | 118 Stanmore Hill HA7 3BY Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 8958700001 | |||||||||
| RONSON, Gerald Maurice | Geschäftsführer | Carrington Chase 54 Winnington Road N2 0TY London | United Kingdom | British | 33068600001 | |||||||||
| ROYDS, David John George | Geschäftsführer | Vine Street W1J 0AH London One United Kingdom | England | British | 141447410004 | |||||||||
| ZELTSER, Lionel Harvey | Geschäftsführer | 59 Michleham Down Woodside Park N12 7JJ London | United Kingdom | British | 82318190001 | |||||||||
| SDG REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900023570001 |
Hat PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Aug. 2009 Geliefert am 19. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower or any obligor to the chargee and the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Okt. 2004 Geliefert am 14. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All interst in the property with short title "stoke", all present and future l/h and f/h property in england and wales, plant and machinery, stocks shares and other securities, licences, insurances, patents, interest in any pension fund, goodwill & uncalled capital, book and other debts, bank accounts, leases and agreements, rental income floating charge all assets situated outwith scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juli 2004 Geliefert am 05. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Basing view basingstoke t/no HP440073, bourne house beckenham t/no SGL553814, marsh leys bedford t/no BD225068 (for further details of property charged please see schedule to form 395) fixed & floating charge over all property & assets present & future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Jan. 2003 Geliefert am 28. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as heron stoke investments (no 4) limited to the chargee and each of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 29. Aug. 2002 Geliefert am 06. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property land and buildings on the north west side of etruria road being site 1A festival park hanley stoke-on-trent t/n SF457290. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0