TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED

TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04469062
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Riverside House
    11-12 Riverside Road
    NR1 1SQ Norwich
    Norfolk
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HALLCO 777 LIMITED25. Juni 200225. Juni 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2012 bis 30. Sept. 2012

    3 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 11. Juli 2012

    • Kapital: GBP 2
    • Kapital: USD 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 16. Dez. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Huberman am 29. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 29. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    17 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Shapoor Naghshineh als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Paul Laurence Huberman als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Peter Allan Dawson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Vanessa Fletcher als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Ian Fox als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAWSON, Peter Allan
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    Geschäftsführer
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor155666140002
    HUBERMAN, Paul Laurence
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    Geschäftsführer
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    FURNESS, Deborah Jane
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    Sekretär
    10 Springfield Road
    Droylsden
    M43 7RE Manchester
    British70000190002
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    British60588430004
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    FLETCHER, Vanessa Anne
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    Geschäftsführer
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    EnglandBritishChartered Accountant101139900001
    FOX, Ian Stuart
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    Geschäftsführer
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    EnglandBritishProperty Developer154671930001
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishProperty Consultant60588430004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector52621450004
    NAVIEDE, Justine Penrose
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Melilia House
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector36734870001
    SMITH, Warren James, Lord Lieutenant
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    145 Old Hall Lane
    Fallowfield
    M14 6HJ Manchester
    Greater Manchester
    EnglandBritishConsultant14246400001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Hat TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 06. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at rugby mill and land to the west of rugby mill gorse street chadderton t/no GM383665 and l/h interest at rugby mill and land to the west of rugby mill gorse street chadderton t/no GM383664 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2002
    Geliefert am 05. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The part freehold property being rugby mill and land to the north west of rugby mill gorse street chadderton and title numbers GM383665 and GM383664. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rugby mill (land lying to the north west of) gorse street, chadderton, oldham, greater manchester t/nos. GM383664 and GM388665. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2000
    Erworben am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 23. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rugby mill, gorse street, chadderton t/no. GM383665 and land lying to the northwest of rugby mill, gorse street t/no. GM383664. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 18. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0