TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04469062 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Riverside House 11-12 Riverside Road NR1 1SQ Norwich Norfolk |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HALLCO 777 LIMITED | 25. Juni 2002 | 25. Juni 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2012 bis 30. Sept. 2012 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 16. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Huberman am 29. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 29. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shapoor Naghshineh als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Laurence Huberman als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Allan Dawson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vanessa Fletcher als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Fox als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWSON, Peter Allan | Geschäftsführer | Montreal Road TN13 2EP Sevenoaks Oak Beams Kent | England | British | Chartered Surveyor | 155666140002 | ||||
HUBERMAN, Paul Laurence | Geschäftsführer | Wildwood Road NW11 6UL London 15 | England | British | Chartered Accountant | 3470530003 | ||||
FURNESS, Deborah Jane | Sekretär | 10 Springfield Road Droylsden M43 7RE Manchester | British | 70000190002 | ||||||
NAGHSHINEH, Ardeshir | Sekretär | Mergate Farmhouse Mergate Lane Bracon Ash NR14 8ER Norwich Norfolk | British | 60588430004 | ||||||
HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
FLETCHER, Vanessa Anne | Geschäftsführer | Wrentham House 86 Southwold Road, Wrentham NR34 7JF Beccles | England | British | Chartered Accountant | 101139900001 | ||||
FOX, Ian Stuart | Geschäftsführer | Dove Barn Queen's Road Hethersett NR9 3DB Norwich | England | British | Property Developer | 154671930001 | ||||
NAGHSHINEH, Ardeshir | Geschäftsführer | Mergate Farmhouse Mergate Lane Bracon Ash NR14 8ER Norwich Norfolk | England | British | Property Consultant | 60588430004 | ||||
NAGHSHINEH, Shapoor | Geschäftsführer | The Old Hall Church Lane Barford NR9 4AY Norwich Norfolk | England | British | Director | 52621450004 | ||||
NAVIEDE, Justine Penrose | Geschäftsführer | Melilia House Mereside Road Mere WA16 6QW Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Director | 36734870001 | ||||
SMITH, Warren James, Lord Lieutenant | Geschäftsführer | 145 Old Hall Lane Fallowfield M14 6HJ Manchester Greater Manchester | England | British | Consultant | 14246400001 | ||||
HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
Hat TARGETFOLLOW (CHADDERTON) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Mai 2005 Geliefert am 06. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at rugby mill and land to the west of rugby mill gorse street chadderton t/no GM383665 and l/h interest at rugby mill and land to the west of rugby mill gorse street chadderton t/no GM383664 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Okt. 2002 Geliefert am 05. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The part freehold property being rugby mill and land to the north west of rugby mill gorse street chadderton and title numbers GM383665 and GM383664. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Rugby mill (land lying to the north west of) gorse street, chadderton, oldham, greater manchester t/nos. GM383664 and GM388665. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 2000 Erworben am 16. Sept. 2002 Geliefert am 23. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Rugby mill, gorse street, chadderton t/no. GM383665 and land lying to the northwest of rugby mill, gorse street t/no. GM383664. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0