DORMCO HBI LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DORMCO HBI LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04482308 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DORMCO HBI LIMITED?
- Großhandel mit einer Vielzahl von Waren (46190) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich DORMCO HBI LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Fouberts Place London W1F 7PA |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DORMCO HBI LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HAMLEYS BEAR INVESTMENT LIMITED | 27. Aug. 2002 | 27. Aug. 2002 |
| DWSCO 2308 LIMITED | 10. Juli 2002 | 10. Juli 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DORMCO HBI LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DORMCO HBI LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Dez. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Jean Marie Robert Le Francois Des Courtis als Direktor am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rudolph Hidalgo als Direktor am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jean-Michel Victor Grunberg als Direktor am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 25. März 2013 bis 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gudjon Karl Reynisson am 31. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 10. Juli 2011 | 16 Seiten | RP04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. März 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DORMCO HBI LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNN, Alasdair Andrew | Sekretär | 2 Fouberts Place London W1F 7PA | British | 109323280001 | ||||||
| DUNN, Alasdair Andrew | Geschäftsführer | 2 Fouberts Place London W1F 7PA | United Kingdom | British | 109323280002 | |||||
| GRUNBERG, Jean-Michel Victor | Geschäftsführer | 2 Fouberts Place London W1F 7PA | France | French | 171137000001 | |||||
| HIDALGO, Rudolph | Geschäftsführer | 2 Fouberts Place London W1F 7PA | United Kingdom | French | 171137010001 | |||||
| LE FRANCOIS DES COURTIS, Jean Marie Robert | Geschäftsführer | 2 Fouberts Place London W1F 7PA | France | French | 173348100001 | |||||
| REYNISSON, Gudjon Karl | Geschäftsführer | Carmel Way TW9 4EY London 1 | United Kingdom | Icelander | 130510730002 | |||||
| BURFORD, Christopher Victor | Sekretär | 19 Copperfields 48 The Avenue BR3 5ER Beckenham Kent | British | 100078720001 | ||||||
| MATHER, Nicholas Charles Holt | Sekretär | Cutmill Bosham PO18 8PS Chichester Newells House West Sussex | British | 135955360001 | ||||||
| PARKER, Ian Robert | Sekretär | 1 Seymour Road W4 5ES London | British | 70871000002 | ||||||
| DWS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023840001 | |||||||
| BURKE, Simon Paul | Geschäftsführer | 35 Chepstow Place W2 4TT London | United Kingdom | Irish | 30017870003 | |||||
| MATHER, Nicholas Charles Holt | Geschäftsführer | Cutmill Bosham PO18 8PS Chichester Newells House West Sussex | United Kingdom | British | 135955360001 | |||||
| OSBORNE, Katherine Anne | Geschäftsführer | Glebe Farm Old Weston Road PE28 5AG Brington Cambs | British | 72141580002 | ||||||
| PARKER, Ian Robert | Geschäftsführer | 1 Seymour Road W4 5ES London | British | 70871000002 | ||||||
| WATKINSON, John Dudley | Geschäftsführer | Fir Tree Cottage 36 West Perry PE18 0BX Huntingdon Cambridgeshire | British | 66949520001 | ||||||
| DWS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023830001 |
Hat DORMCO HBI LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Juni 2011 Geliefert am 15. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Juni 2006 Geliefert am 08. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land under t/ns HD425461, NGL390956 and NGL614726. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 28. Nov. 2003 Geliefert am 15. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A target group debenture supplemental to a composite guararantee and debenture dated 13 august 2003 | Erstellt am 02. Sept. 2003 Geliefert am 09. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 13. Aug. 2003 Geliefert am 28. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Sept. 2002 Geliefert am 20. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0