AGENTPIECE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAGENTPIECE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04482839
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AGENTPIECE LIMITED?

    • Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich AGENTPIECE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AGENTPIECE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AGENTPIECE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für AGENTPIECE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Mary Margaret Turrell als Geschäftsführer am 30. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Ernennung von Ms Maris Vask als Sekretär am 07. Mai 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Brenda Hogan als Sekretär am 07. Mai 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Jan. 2015Replacement This document replaces the AR01 registered on 15/07/2014 as it was not properly delivered

    Ernennung von Mr Julian Gordon Rothwell als Direktor am 04. Sept. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 15. Juli 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Jan. 2015Replaced A replacement AR01 was registered on 07/01/2015

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    15 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 044828390017

    52 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 13. Aug. 2013

    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    13 SeitenAA

    legacy

    17 SeitenMG06

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    Wer sind die Geschäftsführer von AGENTPIECE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VASK, Maris
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Sekretär
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    198800330001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director161364970001
    ROTHWELL, Julian Gordon
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director89680610001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Sekretär
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Geschäftsführer
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    AmericanCompany Director130237490001
    NAGLE, John Timothy
    Falmor
    Falls Road
    IRISH Shankill
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Falmor
    Falls Road
    IRISH Shankill
    Co Dublin
    Ireland
    IrishDirector59921850002
    TURRELL, Mary Margaret
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director92654710001
    WILLIAMSON, John David
    Darton
    Butterhill
    Blessington
    Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Darton
    Butterhill
    Blessington
    Wicklow
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director256560270001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat AGENTPIECE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 14. Nov. 2013
    Geliefert am 19. Nov. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Confirmatory security agreement
    Erstellt am 09. Apr. 2010
    Erworben am 30. Sept. 2011
    Geliefert am 06. Okt. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the transferred assets. Transferred assets means the shares. Shares means all issued shares of cardpoint limited and alphyra holdings limited. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2011Registrierung eines Erwerbs (MG06)
    • 19. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A confirmatory security agreement
    Erstellt am 09. Apr. 2010
    Geliefert am 13. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Okt. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of pledge executed outside the united kingdom over property situated there
    Erstellt am 05. Feb. 2010
    Geliefert am 16. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee in its capacity as independent creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its shares and share rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Okt. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 05. Dez. 2007
    Erworben am 30. Sept. 2011
    Geliefert am 14. Okt. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the transferred assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2011Registrierung eines Erwerbs (MG06)
    • 19. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 05. Dez. 2007
    Geliefert am 15. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 08. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present shares all related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent for Thebeneficiaries)
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 08. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security agent or the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge and security interest the benefit of each of the contracts and all its right title and interest in and to but not its obligations thereunder including without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of any representations warranties undertakings and covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent on Behalfof Itself and the Lenders)
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 08. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent for Thebeneficaries)
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment of claims agreement
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 05. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee or a finance party (or future finance party) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigned and transferred the claims to the chargee, including all future claims as of the moment of their coming into existence. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlad (In Its Capacity as Security Agent Acting Onits Own Behalf and for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 22. Apr. 2005
    Geliefert am 06. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security agent or the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit of each of the contracts, right to monies in connection with any of the dutch newco 1 funding documents or the dutch newco 1 funding documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 2005
    Geliefert am 04. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alphyra Holdings Limited (Acting as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 25. Jan. 2005
    Geliefert am 04. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The claims including all future claims, all rights and any and all insurance claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent for Thefinance Parties)
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Erstellt am 25. Jan. 2005
    Geliefert am 04. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent assignor and/or any other obligor to a finance party and security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present shares and all related rights including dividends, all future shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 02. Apr. 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charging company with full title guarantee assigned to the security agent its acquisition agreement rights and put and call option rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 04. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acquisition agreement rights and put and call option rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent for Thebeneficiaries)
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 04. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land in england and wales vested in the company at the date of accession all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale all plant and machinery all rental and other income and all debts and claims all specified investment securities all derivative rights all insurance or assurance contracts or policies all goodwill and uncalled capital all specified intellectual property the benefit of all agreements and licences all trade debts floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent for Thebeneficiaries)
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0