MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED

MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOORGARTH INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04500290
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    17-19 York Place
    LS1 2EX Leeds
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    YMS PROPERTIES (NO 2) LIMITED31. Juli 200231. Juli 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A1GUKDVN

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Aug. 2012

    Kapitalaufstellung am 07. Aug. 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01
    X1ETI9D7

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 64 Wellington Street Leeds LS1 2EE am 13. Feb. 2012

    1 SeitenAD01
    X12KGSR6

    Ernennung von Mr David Anthony Harrop als Direktor am 01. Nov. 2011

    2 SeitenAP01
    X7IZCYVQ

    Beendigung der Bestellung von John Peter Whiteley als Geschäftsführer am 31. Okt. 2011

    1 SeitenTM01
    X7DKSYVM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    11 SeitenAA
    ABZBIXDN

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    XF2TIWI3

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2010

    12 SeitenAA
    ADPQWP7U

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X19LLMTS

    Ernennung von Mrs Nicola Claire Wood als Sekretär

    1 SeitenAP03
    X19LKMTR

    Beendigung der Bestellung von John Whiteley als Sekretär

    1 SeitenTM02
    X19LJMTQ

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2009

    14 SeitenAA
    AYN0HFOF

    legacy

    4 Seiten363a
    XZ0SNC0N

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. März 2008

    14 SeitenAA
    ALHFJ4DR

    legacy

    4 Seiten363a
    XHJ7P1VP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Feb. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOOD, Nicola Claire
    York Place
    LS1 2EX Leeds
    17-19
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    York Place
    LS1 2EX Leeds
    17-19
    West Yorkshire
    United Kingdom
    153640590001
    HARROP, David Anthony
    York Place
    LS1 2EX Leeds
    17-19
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    York Place
    LS1 2EX Leeds
    17-19
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director164210670001
    MOORE, Cornus
    Im Eichli 9
    6315 Oberageri
    Zug Canton 6315
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Im Eichli 9
    6315 Oberageri
    Zug Canton 6315
    Switzerland
    SwitzerlandSouth AfricanBusinessman87997470001
    VAUGHAN, Timothy Andrew
    Moor Garth
    4 Clifton Road
    LS29 8TT Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moor Garth
    4 Clifton Road
    LS29 8TT Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director93247670001
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    British103719400001
    MCCALL, Rebecca Jane
    52 Rock Lane
    LS13 1DX Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    52 Rock Lane
    LS13 1DX Leeds
    West Yorkshire
    British80214480001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South AfricanFinancial Director40527920003
    WHITELEGG, James
    6 Grange View
    Colton View
    LS15 9LD Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    6 Grange View
    Colton View
    LS15 9LD Leeds
    West Yorkshire
    British98023070001
    WHITELEY, John Peter
    84 Pannal Ash Road
    HG2 9AB Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    84 Pannal Ash Road
    HG2 9AB Harrogate
    North Yorkshire
    British95741380001
    CLARKE, Paul
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    74 Barons Close
    Kirby Muxloe
    LE9 2BW Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant103719400001
    HAMER, John James Arthur
    Norwood Barn Carlton Lane
    LS19 7BG East Carlton
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Norwood Barn Carlton Lane
    LS19 7BG East Carlton
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor83439730001
    HEALEY, Jonathan Andrew
    7 Dickinson Street
    Horsforth
    LS18 5AG Leeds
    West Yorkshire
    Ls18 5ag
    Geschäftsführer
    7 Dickinson Street
    Horsforth
    LS18 5AG Leeds
    West Yorkshire
    Ls18 5ag
    BritishSolicitor96169490001
    PRICE, Charles Ian
    1 Furze Field
    KT22 0UR Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Furze Field
    KT22 0UR Oxshott
    Surrey
    BritishProperty89476690001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South AfricanFinancial Director40527920003
    STASSEN, Carel
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    Geschäftsführer
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    South AfricanManaging Director104942950001
    WHITELEY, John Peter
    84 Pannal Ash Road
    HG2 9AB Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    84 Pannal Ash Road
    HG2 9AB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director95741380001

    Hat MOORGARTH INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Feb. 2007
    Geliefert am 27. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at whitemoss business park, moss lane, skelmersdale t/n LA934742. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Nov. 2006
    Geliefert am 08. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43-51 cookridge street leeds t/n WYK390981 and WYK695865,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    119-125 marygate berwick upon tweed t/no ND96168. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 middle street consett t/no DU176962. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    "Abbeycrest building" wilmington grove/barrack street sheepscar leeds t/nos WYK585103 and YWE66038. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 23RD november 2006 and
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 13. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The property k/a unit 16 boundary road, heathfield industrial estate, prestwick.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 20 october 2006 and
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    7-11 main street baillieston.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 october 2006 and
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Unit 16 boundary road heathfield industrial estate prestwick.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 19TH october 2006 and
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    130/132 hish street irvine.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2006 and
    Erstellt am 10. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole 42 high street, johnstone t/no REN39022.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2006 and
    Erstellt am 10. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole 63/71 dalrymple street, girvan t/no AYR24077.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2006 and
    Erstellt am 10. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole those four lots of ground at the north end of urquhart's vennel lying in the burgh of forres and county of moray. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2006 and
    Erstellt am 10. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole unit 1, 36 nicolson street, greenock t/no REN93728.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2006 and
    Erstellt am 10. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole 213 high street, perth t/no PTH2929.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2005
    Geliefert am 14. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 76 to 82 (even) and 82A senhouse street maryport t/n CU33 and secondly f/h property being 41 waterloo road blyth t/n ND24961. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 27. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 15. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    119-125 marygate berwick upon tweed t/n ND96168 19 & 21 middle street consett t/n DU176962 41 waterloo road blyth t/n ND24961 * please refer to form 395 for further properties charged *. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 15. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 15. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south east side of bath road felling t/n TY170043 land lying to the north of collingwood gardens felling t/n TY170043 98 -104(even) high street felling t/n TY223034 * please refer to form 395 for further properties charged *. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 15. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 27 may 2003 and
    Erstellt am 08. Mai 2003
    Geliefert am 11. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 40-44 main street and 7 mill street rutherglen t/n LAN113712, 27,29 and 31 west main street whitburn bathgate t/n WLN3543 (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26 may 2003 and
    Erstellt am 08. Mai 2003
    Geliefert am 11. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 4/8 francis street isle of lkewis stornoway together with the buildings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 27 may 2003 and
    Erstellt am 08. Mai 2003
    Geliefert am 11. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 61 high street leven t/n FFE9278, 213 high street perth t/n PTH2929, 46-48 bo'ness road grangemouth and la porte precinct grangemouth t/n STG4470 (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26 may 2003 and
    Erstellt am 08. Mai 2003
    Geliefert am 11. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The four lots of ground at the north end of urquhart's vennel lying in t he burgh of forres and county of morays forming 42 high street forres together with all buildings fixtures and fittings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0