SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04502016 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED | 23. Okt. 2002 | 23. Okt. 2002 |
| SOUTHWEST LIMITED | 02. Aug. 2002 | 02. Aug. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| JOYCE, Meriel Lucy Ann | Sekretär | 21 Easter Steil EH10 5XE Edinburgh | British | 16385330010 | ||||||
| KAUL, Sheila | Sekretär | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305970001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Bevollmächtigter Sekretär | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| ASARIA, Mohamed Saleem | Geschäftsführer | Fringewood Close HA6 2TB Northwood 8 Middlesex | England | British | 13927880001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FINNIS, Pam | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 133719530001 | |||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GROOMBRIDGE, Kevin John | Geschäftsführer | 51 Old Croft Road ST17 0NL Stafford | England | British | 105722880001 | |||||
| JOYCE, Martin Patrick | Geschäftsführer | La Rue A St Peter Port GY1 1QG Guernsey | United Kingdom | British | 27130160009 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MALHAM, Janette | Geschäftsführer | The Limekilns 9a Elm Grove TS26 8LZ Hartlepool | England | British | 91088900003 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Geschäftsführer | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MCQUAID, Michael James | Geschäftsführer | Baily Bach Cobham Way KT24 5BH East Horsley Surrey | United Kingdom | British | 89052830001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| MURRAY, Andrew John | Geschäftsführer | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| MURRAY, Andrew John | Geschäftsführer | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| POYNTON, Ellen | Geschäftsführer | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | 89071020004 | |||||
| RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STEIN, Anthony Karl | Geschäftsführer | 9 Birmingham Road Coughton B49 5HR Alcester | United Kingdom | British | 109518530001 | |||||
| WILSON, Mark Stephen | Geschäftsführer | 9 Wheatear Lane Ingleby Barwick TS17 0TB Stockton On Tees | British | 90893350001 | ||||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 07. Mai 2003 Geliefert am 15. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Mai 2003 Geliefert am 10. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 29. Apr. 2003 Geliefert am 09. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit the interest the deposit account and the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 29. Apr. 2003 Geliefert am 08. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Apr. 2003 Geliefert am 02. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Apr. 2003 Geliefert am 02. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 24. März 2003 Geliefert am 03. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 24. März 2003 Geliefert am 27. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. März 2003 Geliefert am 03. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. März 2003 Geliefert am 25. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Jan. 2003 Geliefert am 05. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Jan. 2003 Geliefert am 01. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0