THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED

THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04508367
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CDS AND HORNBY GROUP LIMITED09. Jan. 200309. Jan. 2003
    PLUS HOUSING GROUP LIMITED09. Aug. 200209. Aug. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2020

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2019

    12 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street Liverpool Merseyside L1 9EF zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 22. Aug. 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Juli 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    10 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Edward Murtha als Geschäftsführer am 12. März 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    21 SeitenAA

    Ernennung von Mr John Kent als Sekretär am 01. Sept. 2017

    2 SeitenAP03

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Beendigung der Bestellung von Frank Harasiwka als Sekretär am 01. Sept. 2017

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr John Ashley Kent als Direktor am 31. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Claire Griffiths als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von George James Davies als Geschäftsführer am 15. Mai 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Dr Ann Hoskins als Direktor am 19. Mai 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Sir Peter Fahy als Direktor am 19. Mai 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Robert James O'malley als Direktor am 17. März 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    24 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Linda Minnis als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Barwise als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mervyn Jones als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    7 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KENT, John
    Heath Lane
    CH3 5SX Chester
    22
    United Kingdom
    Sekretär
    Heath Lane
    CH3 5SX Chester
    22
    United Kingdom
    241405130001
    FAHY, Peter, Sir
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritish218615150001
    GOWTHORPE, Brian John
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritish70266240001
    HOSKINS, Ann, Dr
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    United KingdomIrish122996890001
    KENT, John Ashley
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    United KingdomBritish236201590001
    LAWLER, Robin
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritish201038640001
    O'MALLEY, Robert James
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritish139467140001
    PALMER, Sandra Louise
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Geschäftsführer
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritish147351690001
    CAREY, Alison Lesley
    Statham Road
    Bidston
    CH43 7XS Prenton
    2
    Wirral
    Sekretär
    Statham Road
    Bidston
    CH43 7XS Prenton
    2
    Wirral
    British135393860001
    COOPER, Matthew John
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    207698340001
    HARASIWKA, Frank
    13 - 15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    Merseyside
    England
    Sekretär
    13 - 15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    Merseyside
    England
    210968710002
    JONES, Robert
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    Sekretär
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    British84381750002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARWISE, Anthony Jevon
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish200220040001
    BOWDEN, Stephen
    1 Hollybrook Dene
    Romiley
    SK6 4ES Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Hollybrook Dene
    Romiley
    SK6 4ES Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish109826720002
    BUDDEN, Lesley Clare
    The Old Barn
    Llysgwyddfid
    LH7 4NW Trevddyn
    Flintshire
    Geschäftsführer
    The Old Barn
    Llysgwyddfid
    LH7 4NW Trevddyn
    Flintshire
    WalesWelsh109826700001
    CONNOR, Christopher Gerard
    370 Liverpool Road
    Great Sankey
    WA5 1RU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    370 Liverpool Road
    Great Sankey
    WA5 1RU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish47111220001
    CROSS, Vivien Margaret
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish149285360001
    DAVIES, George James
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish169472780002
    DEEPWELL, Sasha Helen
    99 Lyndhurst Avenue
    L18 8AR Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    99 Lyndhurst Avenue
    L18 8AR Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish100031900001
    GRIFFITHS, Claire
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish106594690001
    HARRIS, Paul Patrick
    1 Endfield Park
    L19 9BR Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    1 Endfield Park
    L19 9BR Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish84381680001
    JONES, Mervyn
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish78600880001
    JONES, Robert
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    Geschäftsführer
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritish84381750002
    MASON, Gary Stamford
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish96986140001
    MILROY, Kim
    4 Runshaw Lane
    PR7 6AU Euxton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 Runshaw Lane
    PR7 6AU Euxton
    Lancashire
    British109826710001
    MINNIS, Linda
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish74216060003
    MORRIS, David Roger
    4 St Annes Road
    Aigburth
    L17 6BW Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    4 St Annes Road
    Aigburth
    L17 6BW Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish6484880001
    MURDEN, Gerard Francis
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish228375200002
    MURTHA, Thomas Edward, Dr
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish137402260001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    PARRY, Stephen
    279 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    279 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish10538330002
    PATTERSON, Paul
    73 South Meade
    Maghull
    L31 8EG Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    73 South Meade
    Maghull
    L31 8EG Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish110229870001
    PERRY, Kenneth William
    Casa
    Old School House Lane, Winwick
    WA2 8SQ Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Casa
    Old School House Lane, Winwick
    WA2 8SQ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish84381830002
    SHAW, Peter
    Orchard Way
    Kelsall
    CW6 0PB Tarporley
    The Cottage
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Orchard Way
    Kelsall
    CW6 0PB Tarporley
    The Cottage
    Cheshire
    England
    EnglandBritish141110430001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Plus Dane (Merseyside) Housing Association Limited
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    England
    01. Juli 2016
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    England
    Nein
    RechtsformIndustrial And Provident Society
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    RegistrierungsortEngland And Wales
    RegistrierungsnummerIp031012
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold land lying on the north side of huddersfield road, delph, oldham (title number: MAN56760). Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 2011
    Geliefert am 27. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property at huddersfield road, delph t/no MAN56760.
    Berechtigte Personen
    • Taggart Homes Lumb Mill Delph Limited (In Administration)
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 2009
    Geliefert am 15. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Supermarket at essington road new invention willenhall t/nos. WM473041 and WM465107 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 2009
    Geliefert am 15. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Supermarket at north road holywell WA350272 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 2009
    Geliefert am 15. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Supermarket at new road willenhall t/no. WM423682 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 2007
    Geliefert am 03. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Beetham court and 8 pall mall liverpool f/h t/nos: MS40440 and MS276681. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 17. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit d senator point hornhouse lane knowsley industrial park knowsley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 28. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • New Generation Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 28. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greater Hornby Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 28. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cds Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 12. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H building 1 site 1 access 26 whitehall road cleckheaton kirklees t/n WYK754206. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 22. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 1300, lingley mere business park warrington part t/no CH531404. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plots 395/396 & 397 carrington park battersby lane warrington cheshire and plots 227/235/236 & 237 sadlers park burslem stoke on trent staffordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a vista, st davids park, flintshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Juli 2018Beginn der Liquidation
    19. Aug. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0