THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04508367 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 82 St John Street EC1M 4JN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CDS AND HORNBY GROUP LIMITED | 09. Jan. 2003 | 09. Jan. 2003 |
| PLUS HOUSING GROUP LIMITED | 09. Aug. 2002 | 09. Aug. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2020 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2019 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street Liverpool Merseyside L1 9EF zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 22. Aug. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 10 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Edward Murtha als Geschäftsführer am 12. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr John Kent als Sekretär am 01. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frank Harasiwka als Sekretär am 01. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Ashley Kent als Direktor am 31. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Griffiths als Geschäftsführer am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von George James Davies als Geschäftsführer am 15. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Dr Ann Hoskins als Direktor am 19. Mai 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Sir Peter Fahy als Direktor am 19. Mai 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert James O'malley als Direktor am 17. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Linda Minnis als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Barwise als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mervyn Jones als Geschäftsführer am 15. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENT, John | Sekretär | Heath Lane CH3 5SX Chester 22 United Kingdom | 241405130001 | |||||||
| FAHY, Peter, Sir | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | England | British | 218615150001 | |||||
| GOWTHORPE, Brian John | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | England | British | 70266240001 | |||||
| HOSKINS, Ann, Dr | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | United Kingdom | Irish | 122996890001 | |||||
| KENT, John Ashley | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | United Kingdom | British | 236201590001 | |||||
| LAWLER, Robin | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | England | British | 201038640001 | |||||
| O'MALLEY, Robert James | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | England | British | 139467140001 | |||||
| PALMER, Sandra Louise | Geschäftsführer | St John Street EC1M 4JN London 82 | England | British | 147351690001 | |||||
| CAREY, Alison Lesley | Sekretär | Statham Road Bidston CH43 7XS Prenton 2 Wirral | British | 135393860001 | ||||||
| COOPER, Matthew John | Sekretär | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | 207698340001 | |||||||
| HARASIWKA, Frank | Sekretär | 13 - 15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Baltimore Buildings Merseyside England | 210968710002 | |||||||
| JONES, Robert | Sekretär | 90 Ryburn Road L39 4SD Ormskirk Lancashire | British | 84381750002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARWISE, Anthony Jevon | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 200220040001 | |||||
| BOWDEN, Stephen | Geschäftsführer | 1 Hollybrook Dene Romiley SK6 4ES Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 109826720002 | |||||
| BUDDEN, Lesley Clare | Geschäftsführer | The Old Barn Llysgwyddfid LH7 4NW Trevddyn Flintshire | Wales | Welsh | 109826700001 | |||||
| CONNOR, Christopher Gerard | Geschäftsführer | 370 Liverpool Road Great Sankey WA5 1RU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 47111220001 | |||||
| CROSS, Vivien Margaret | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 149285360001 | |||||
| DAVIES, George James | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 169472780002 | |||||
| DEEPWELL, Sasha Helen | Geschäftsführer | 99 Lyndhurst Avenue L18 8AR Liverpool Merseyside | England | British | 100031900001 | |||||
| GRIFFITHS, Claire | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 106594690001 | |||||
| HARRIS, Paul Patrick | Geschäftsführer | 1 Endfield Park L19 9BR Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 84381680001 | |||||
| JONES, Mervyn | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 78600880001 | |||||
| JONES, Robert | Geschäftsführer | 90 Ryburn Road L39 4SD Ormskirk Lancashire | United Kingdom | British | 84381750002 | |||||
| MASON, Gary Stamford | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 96986140001 | |||||
| MILROY, Kim | Geschäftsführer | 4 Runshaw Lane PR7 6AU Euxton Lancashire | British | 109826710001 | ||||||
| MINNIS, Linda | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 74216060003 | |||||
| MORRIS, David Roger | Geschäftsführer | 4 St Annes Road Aigburth L17 6BW Liverpool Merseyside | England | British | 6484880001 | |||||
| MURDEN, Gerard Francis | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 228375200002 | |||||
| MURTHA, Thomas Edward, Dr | Geschäftsführer | Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Merseyside | England | British | 137402260001 | |||||
| OWEN, Michael Barry | Geschäftsführer | Barrow Lane Great Barrow CH3 7HW Chester The Old Rectory Cheshire | England | British | 69716360003 | |||||
| PARRY, Stephen | Geschäftsführer | 279 South Ferry Quay L3 4EE Liverpool Merseyside | England | British | 10538330002 | |||||
| PATTERSON, Paul | Geschäftsführer | 73 South Meade Maghull L31 8EG Liverpool Merseyside | England | British | 110229870001 | |||||
| PERRY, Kenneth William | Geschäftsführer | Casa Old School House Lane, Winwick WA2 8SQ Warrington Cheshire | England | British | 84381830002 | |||||
| SHAW, Peter | Geschäftsführer | Orchard Way Kelsall CW6 0PB Tarporley The Cottage Cheshire England | England | British | 141110430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus Dane (Merseyside) Housing Association Limited | 01. Juli 2016 | 13-15 Rodney Street L1 9EF Liverpool Baltimore Buildings England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 07. Juni 2013 Geliefert am 14. Juni 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Freehold land lying on the north side of huddersfield road, delph, oldham (title number: MAN56760). Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Jan. 2011 Geliefert am 27. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property at huddersfield road, delph t/no MAN56760. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 2009 Geliefert am 15. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Supermarket at essington road new invention willenhall t/nos. WM473041 and WM465107 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 2009 Geliefert am 15. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Supermarket at north road holywell WA350272 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 2009 Geliefert am 15. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Supermarket at new road willenhall t/no. WM423682 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Beetham court and 8 pall mall liverpool f/h t/nos: MS40440 and MS276681. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Aug. 2007 Geliefert am 17. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit d senator point hornhouse lane knowsley industrial park knowsley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 28. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 28. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 28. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 12. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. März 2007 Geliefert am 31. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H building 1 site 1 access 26 whitehall road cleckheaton kirklees t/n WYK754206. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Feb. 2007 Geliefert am 22. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1300, lingley mere business park warrington part t/no CH531404. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 2007 Geliefert am 27. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 395/396 & 397 carrington park battersby lane warrington cheshire and plots 227/235/236 & 237 sadlers park burslem stoke on trent staffordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 2006 Geliefert am 19. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a vista, st davids park, flintshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0