CRAIGSHAW PROPERTIES LTD
Überblick
| Unternehmensname | CRAIGSHAW PROPERTIES LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04511142 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CRAIGSHAW PROPERTIES LTD?
- (7499) /
Wo befindet sich CRAIGSHAW PROPERTIES LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor Manchester House 86 Princess Street M1 6NP Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRAIGSHAW PROPERTIES LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CRAIGSHAW PROPERTIES LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Integra Trustees Limited am 13. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Esty Nemetsky als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Chaim Shimon Lebrecht als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Bernard Janus Lebrecht als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CRAIGSHAW PROPERTIES LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRECHT, Refoel | Sekretär | 6 Saltire Gardens M7 4BG Salford Lancashire | British | 81709090001 | ||||||||||
| LEBRECHT, Bernard Janus | Geschäftsführer | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancashire | United Kingdom | English | 142802040001 | |||||||||
| LEBRECHT, Chaim Shimen | Geschäftsführer | Tully Street M7 2BB Salford 23 Lancashire | England | British | 34805230002 | |||||||||
| INTEGRA TRUSTEES LIMITED | Geschäftsführer | Manchester House 86 Princess Street M1 6NP Manchester 3rd Floor Lancashire |
| 114974380001 | ||||||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road M7 4AS Salford | 900014920001 | |||||||||||
| LEIGH, Rachel | Geschäftsführer | 6 Okeover Road M7 4JX Salford Lancashire | British | 84919170001 | ||||||||||
| NEMETSKY, Esty | Geschäftsführer | Richmond Avenue M25 0LW Prestwich 65 Lancashire | United Kingdom | British | 133848410001 | |||||||||
| ROSENBERG, Bryna | Geschäftsführer | 1 Old Hall Road M7 4JJ Salford Lancashire | British | 110755180001 | ||||||||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
Hat CRAIGSHAW PROPERTIES LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A standard security which was presented for registration in scotland on 05/04/04 and | Erstellt am 17. März 2004 Geliefert am 10. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole those four areas or pieces of ground lying generally to the south of craigshaw road aberdeen all and whole those subjects registered t/n KNC821 together with the whole buildings and other erections. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 12TH november 2003 and | Erstellt am 22. Okt. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property known as pavillion 5 craigshaw business park craigshaw road aberdeen t/n KNC8821. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security dated 20TH january 2003 which was presented for registration in scotland on 31ST january 2003 | Erstellt am 31. Jan. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole those five areas or pieces of ground lying generally to the south of craigshaw road aberdeen. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 4TH november 2002 | Erstellt am 01. Okt. 2002 Geliefert am 12. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole those areas and pieces of ground lying generally to the south of craigshaw road aberdeen, all fixtures and fittings therein and thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 01. Okt. 2002 Geliefert am 17. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whole of the property (including uncalled capital) in the property and undertaking of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0