ARMSTRONG HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARMSTRONG HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04511439
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    • Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen
    • Sonstige Bauinstallationen (43290) / Bauwesen

    Wo befindet sich ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Owlwood House Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erfüllung der Belastung 045114390006 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2020 bis 30. Juni 2020

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2019

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2018

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Nicholas William Armstrong als Geschäftsführer am 30. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2017

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Apr. 2017

    • Kapital: GBP 100
    3 SeitenSH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Feb. 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 045114390007 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Eintragung der Belastung 045114390007, erstellt am 03. Feb. 2015

    40 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARMSTRONG, Mark
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    England
    Geschäftsführer
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    England
    EnglandBritish84005850006
    ARMSTRONG, Caroline Louise
    Whinfield
    Adel
    LS16 6AB Leeds
    6a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Whinfield
    Adel
    LS16 6AB Leeds
    6a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British84005930003
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    ARMSTRONG, Caroline Louise
    Whinfield
    Adel
    LS16 6AB Leeds
    6a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Whinfield
    Adel
    LS16 6AB Leeds
    6a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish84005930003
    ARMSTRONG, Nicholas William
    Main Street
    Menston
    LS29 6HU Ilkley
    139
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Main Street
    Menston
    LS29 6HU Ilkley
    139
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish183460520001
    CAIN, Terence
    Ardlui
    Killingworth Drive, Westmoor
    NE12 7ES Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Ardlui
    Killingworth Drive, Westmoor
    NE12 7ES Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish113369730001
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ARMSTRONG HOMES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Mark Armstrong
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    01. Juli 2016
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr Nicholas William Armstrong
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    01. Juli 2016
    Easingwold Road
    Stillington
    YO61 1LR York
    Owlwood House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ARMSTRONG HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Feb. 2015
    Geliefert am 17. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land at 48 hawthorne spinney york.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Nov. 2014
    Geliefert am 02. Dez. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Sept. 2007
    Geliefert am 03. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 2, 6 whinfield adel leeds west yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 10. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Half moon garage, half moon street, 1 stakeford lane, stakeford, northumberland. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 05. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the west side of burradon road burradon northumberland t/no TY337051. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 05. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at sacriston lane witton gilbert county durham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Nov. 2002
    Geliefert am 27. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0