LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04512364 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2017 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 17 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2017 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alistair James Neil Hewitt als Geschäftsführer am 19. Okt. 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 18th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 13. Mai 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. März 2016
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Alistair James Neil Hewitt als Direktor am 10. Apr. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary John Mccabe als Geschäftsführer am 10. Apr. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Burnett als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Gary John Mccabe als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOFI, Christakis, Mr. | Sekretär | 10 Litchfield Way NW11 6NJ London | British | 67125820002 | ||||||
| KASCH, Peter Carwile | Geschäftsführer | Filston Oast Filston Lane TN14 5JU Shoreham Kent | United Kingdom | British | 61386600003 | |||||
| MCMAHON, James Cairns | Geschäftsführer | Greenacres Kerrix Road KA1 5QP Symington Ayrshire | Scotland | British | 159708270001 | |||||
| WILSON, Guy Ian Swinburn | Geschäftsführer | Culham House High Street Culham OX14 4NA Abingdon Oxfordshire | England | British | 141163410001 | |||||
| SCOTT, Keith | Sekretär | Clarendon Road HP16 0PL Prestwood Michaelmas Farm Buckinghamshire | British | 141163370001 | ||||||
| BURNESS SOLICITORS | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Geschäftsführer | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | 73849040001 | |||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Geschäftsführer | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||
| BURNETT, Neil Scott | Geschäftsführer | Hermitage Gardens EH10 6DL Edinburgh 1 Scotland United Kingdom | Scotland | British | 93937250003 | |||||
| HEWITT, Alistair James Neil | Geschäftsführer | Annickbank Stewarton KA3 5QT Kilmarnock 12 Ayrshire | Scotland | British | 113081830001 | |||||
| KERR, Donald | Geschäftsführer | 28 Burnbank EH20 9NE Straiton Midlothian | British | 84247450001 | ||||||
| MCCABE, Gary John | Geschäftsführer | Cleuch Avenue EH23 4RP North Middleton 6 Midlothian Scotland | Scotland | British | 139525550001 | |||||
| SELLAR, Gillian Christine | Geschäftsführer | 112 Seaview Terrace EH15 2HQ Edinburgh Midlothian | British | 107180940001 | ||||||
| BURNESS (DIRECTORS) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900019120001 |
Hat LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over cash deposit | Erstellt am 02. Juli 2004 Geliefert am 16. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 25. Juni 2004 Geliefert am 29. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Secured assets: the existing shares, the further shares and the related rights;. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 12. Jan. 2004 Geliefert am 16. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 18. Sept. 2003 Geliefert am 25. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 05. März 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The secured assets being the existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 19. Nov. 2002 Geliefert am 22. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The existing shares, the further shares and the related rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 06. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The exixting shares, the further shares and the related rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 06. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0