LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOTHIAN FIFTY (150) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04512364
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2017

    17 SeitenLIQ03

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    17 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2017

    12 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Alistair James Neil Hewitt als Geschäftsführer am 19. Okt. 2016

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 18th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 13. Mai 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Apr. 2016

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 Seiten4.70

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. März 2016

    • Kapital: GBP 383,909
    4 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 03. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Ernennung von Mr Alistair James Neil Hewitt als Direktor am 10. Apr. 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gary John Mccabe als Geschäftsführer am 10. Apr. 2015

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 01. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    15 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Neil Burnett als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Gary John Mccabe als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Sekretär
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    British67125820002
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Geschäftsführer
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritish61386600003
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish141163410001
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    British141163370001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Geschäftsführer
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BURNETT, Neil Scott
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish93937250003
    HEWITT, Alistair James Neil
    Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    12
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    12
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    KERR, Donald
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    Geschäftsführer
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    British84247450001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish139525550001
    SELLAR, Gillian Christine
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    British107180940001
    BURNESS (DIRECTORS) LIMITED
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900019120001

    Hat LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 02. Juli 2004
    Geliefert am 16. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 25. Juni 2004
    Geliefert am 29. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Secured assets: the existing shares, the further shares and the related rights;.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, Acting as Security Trustee for the Bank Andthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 29. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 12. Jan. 2004
    Geliefert am 16. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for the Bank Andthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Bank and Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 13. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The secured assets being the existing shares, the further shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Bank and Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 13. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 19. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The existing shares, the further shares and the related rights.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for the Bank Andthe Finance Parties as Hereinafter Defined
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 06. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The exixting shares, the further shares and the related rights.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 06. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat LOTHIAN FIFTY (150) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Apr. 2018Soll aufgelöst werden am
    26. Apr. 2016Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0