04516845 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 04516845 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04516845 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 04516845 LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich 04516845 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 04516845 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 04516845 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 14 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2017 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2016 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Apr. 2015 | 13 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU zum Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 14. Apr. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed rso\certificate issued on 13/04/15 | CERTNM | |||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 13 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Okt. 2011 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Miles Carter als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Miles Carter als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 7 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 50 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Ryes School Ryes Lane Little Henny Sudbury Suffolk CO10 7EA* am 10. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 2.12B | |||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 04516845 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANCELLOR, Anthony James | Geschäftsführer | Rivermead Ringland Lane Costessey NR8 5BG Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 61433800001 | |||||
| FARROW, William John | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp | England | British | 45862810004 | |||||
| CARTER, Miles Everitt | Sekretär | 30 Brook Street Glemsford CO10 7PL Sudbury Suffolk | British | 32759540003 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| THOMPSON SMITH & PUXON (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Sekretär | 4 North Hill CO1 1EB Colchester Essex | 138398140001 | |||||||
| CARTER, Miles Everitt | Geschäftsführer | 30 Brook Street Glemsford CO10 7PL Sudbury Suffolk | England | British | 32759540003 | |||||
| CARTER, Miles Everitt | Geschäftsführer | The Abbey Gloucester Road Grovesend Thornbury BS35 3TR Bristol Somerset | British | 32759540002 | ||||||
| CLARKE, Janet Betty | Geschäftsführer | 9 Park Lane Bulmer Tye CO10 7EQ Sudbury Suffolk | British | 60185890001 | ||||||
| FRIEDAG, Thomas Torsten | Geschäftsführer | 62 Richard Burn Way CO10 1SY Sudbury Suffolk | Deutsch | 71381330001 | ||||||
| GILES, John | Geschäftsführer | 11 Church Hill Earls Colne CO6 2RG Colchester Essex | British | 86473960001 | ||||||
| HUNT, Linda Ann | Geschäftsführer | 16 Station Road CO10 2SS Sudbury Suffolk | British | 85719150001 | ||||||
| LONG, Christian Julius George | Geschäftsführer | 49 High Street Great Wilbraham CB21 5JD Cambridge Cambridgeshire | England | British | 121038030001 | |||||
| PESTER, James Ravenhill | Geschäftsführer | 23 Broome Street Gleat Cornard CO10 0TT Sudbury | British | 71228970002 | ||||||
| TRIGGS, Carol Ann | Geschäftsführer | The Studio Cock Road Little Maplestead CO9 2SH Halstead Essex | British | 85937620001 | ||||||
| TRIGGS, Carol Ann | Geschäftsführer | The Studio Cock Road Little Maplestead CO9 2SH Halstead Essex | British | 85937620001 | ||||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Hat 04516845 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fee agreement second charge | Erstellt am 04. Okt. 2010 Geliefert am 21. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 29 head lane great cornard suffolk: babergh t/n SK121788 by way of fixed charge the charged assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 04. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 04. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 29 head lane great cornard t/no SK121788 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 2004 Geliefert am 01. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property k/a kesgrave hall and surrounding buildings, kesgrave and little bealing, IP5 2PU t/n SK150297 but excluding the land comprising t/n SK237817 together with the f/h property being woodland k/aland on the north side of main road, kesgrave t/n SK152808. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 2003 Geliefert am 09. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The bungalow, kesgrave hall, hall road, kesgrave t/no SK150297. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Nov. 2003 Geliefert am 01. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as the white house, kesgrave hall, hall road, kesgrave IP5 5PU. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 27. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums together with all interest and other amounts accruing on such sums standing to the credit of the account numbered 06000329. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 2003 Geliefert am 13. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 29 head lane great cornard sudbury t/n SK121788. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 31. Jan. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Life assurance policy no X74428829 with standard life assurance company over the life of thomas torsten friedag all sums assured by it and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 12. Nov. 2002 Geliefert am 25. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit as deposited in the charged account being the account (in whatever currency) of the company with the governor and company of the bank of scotland it it's branch office at 35 princes street ipswich IP1 1AE now numbered 6000329 as the same may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 12. Nov. 2002 Geliefert am 25. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the deposit being all sums (in whatever currency) of the company with the governor and company of the bank of scotland at branch offices at 35 princes street ipswich IP1 1AE now numbered 6000337 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time as placed in the charged account with the above number. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 25. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat 04516845 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0