04516845 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname04516845 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04516845
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 04516845 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich 04516845 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 04516845 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für 04516845 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    14 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2017

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2016

    11 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Apr. 2015

    13 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU zum Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 14. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed rso\certificate issued on 13/04/15
    CERTNM

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    13 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Okt. 2011

    21 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Miles Carter als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Miles Carter als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    50 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Ryes School Ryes Lane Little Henny Sudbury Suffolk CO10 7EA* am 10. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    2.12B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    16 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 13. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 251,250
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von 04516845 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHANCELLOR, Anthony James
    Rivermead Ringland Lane
    Costessey
    NR8 5BG Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Rivermead Ringland Lane
    Costessey
    NR8 5BG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish61433800001
    FARROW, William John
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    Geschäftsführer
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Grant Thornton Uk Llp
    EnglandBritish45862810004
    CARTER, Miles Everitt
    30 Brook Street
    Glemsford
    CO10 7PL Sudbury
    Suffolk
    Sekretär
    30 Brook Street
    Glemsford
    CO10 7PL Sudbury
    Suffolk
    British32759540003
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    THOMPSON SMITH & PUXON (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    4 North Hill
    CO1 1EB Colchester
    Essex
    Sekretär
    4 North Hill
    CO1 1EB Colchester
    Essex
    138398140001
    CARTER, Miles Everitt
    30 Brook Street
    Glemsford
    CO10 7PL Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    30 Brook Street
    Glemsford
    CO10 7PL Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish32759540003
    CARTER, Miles Everitt
    The Abbey Gloucester Road
    Grovesend Thornbury
    BS35 3TR Bristol
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Abbey Gloucester Road
    Grovesend Thornbury
    BS35 3TR Bristol
    Somerset
    British32759540002
    CLARKE, Janet Betty
    9 Park Lane
    Bulmer Tye
    CO10 7EQ Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    9 Park Lane
    Bulmer Tye
    CO10 7EQ Sudbury
    Suffolk
    British60185890001
    FRIEDAG, Thomas Torsten
    62 Richard Burn Way
    CO10 1SY Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    62 Richard Burn Way
    CO10 1SY Sudbury
    Suffolk
    Deutsch71381330001
    GILES, John
    11 Church Hill
    Earls Colne
    CO6 2RG Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    11 Church Hill
    Earls Colne
    CO6 2RG Colchester
    Essex
    British86473960001
    HUNT, Linda Ann
    16 Station Road
    CO10 2SS Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    16 Station Road
    CO10 2SS Sudbury
    Suffolk
    British85719150001
    LONG, Christian Julius George
    49 High Street
    Great Wilbraham
    CB21 5JD Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    49 High Street
    Great Wilbraham
    CB21 5JD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish121038030001
    PESTER, James Ravenhill
    23 Broome Street
    Gleat Cornard
    CO10 0TT Sudbury
    Geschäftsführer
    23 Broome Street
    Gleat Cornard
    CO10 0TT Sudbury
    British71228970002
    TRIGGS, Carol Ann
    The Studio
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    The Studio
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    British85937620001
    TRIGGS, Carol Ann
    The Studio
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    The Studio
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    British85937620001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Hat 04516845 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 04. Okt. 2010
    Geliefert am 21. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    29 head lane great cornard suffolk: babergh t/n SK121788 by way of fixed charge the charged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 04. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 04. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 head lane great cornard t/no SK121788 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 2004
    Geliefert am 01. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/a kesgrave hall and surrounding buildings, kesgrave and little bealing, IP5 2PU t/n SK150297 but excluding the land comprising t/n SK237817 together with the f/h property being woodland k/aland on the north side of main road, kesgrave t/n SK152808. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Together with Its Successors and Assignees
    Transaktionen
    • 01. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The bungalow, kesgrave hall, hall road, kesgrave t/no SK150297. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Geliefert am 01. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as the white house, kesgrave hall, hall road, kesgrave IP5 5PU. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 10. Okt. 2003
    Geliefert am 27. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All sums together with all interest and other amounts accruing on such sums standing to the credit of the account numbered 06000329. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2003
    Geliefert am 13. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 29 head lane great cornard sudbury t/n SK121788. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 31. Jan. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Life assurance policy no X74428829 with standard life assurance company over the life of thomas torsten friedag all sums assured by it and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 12. Nov. 2002
    Geliefert am 25. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit as deposited in the charged account being the account (in whatever currency) of the company with the governor and company of the bank of scotland it it's branch office at 35 princes street ipswich IP1 1AE now numbered 6000329 as the same may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 12. Nov. 2002
    Geliefert am 25. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the deposit being all sums (in whatever currency) of the company with the governor and company of the bank of scotland at branch offices at 35 princes street ipswich IP1 1AE now numbered 6000337 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time as placed in the charged account with the above number.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 25. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat 04516845 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. März 2012Ende der Verwaltung
    28. Apr. 2011Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    James Henry Stewart-Koster
    30 Finsbury Square
    London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    London
    2
    DatumTyp
    28. Apr. 2015Ende der Verwaltung
    20. März 2015Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    3
    DatumTyp
    28. Apr. 2015Beginn der Liquidation
    17. Jan. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0