PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04518395 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O SILKE AND CO LTD 1st Floor Consort House Waterdale DN1 3HR Doncaster |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2019 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 11 Seiten | CVA4 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 7 & 8 27 Black Moor Road Ebblake Industrial Estate Verwood BH31 6BE England zum 1st Floor Consort House Waterdale Doncaster DN1 3HR am 30. Mai 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 11 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 045183950006 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 14 Seiten | CVA1 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Aufhebung der Vergleichsverfahren | 1 Seiten | OCRESCIND | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Cessation of Amy Christina Mckellar as a person with significant control on 18. Sept. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Amy Christina Mckellar as a person with significant control on 18. Sept. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mohammed Yasin als Geschäftsführer am 22. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Amy Christina Mckellar als Geschäftsführer am 18. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hafiz Chaudhry Ali als Geschäftsführer am 18. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 045183950006, erstellt am 24. Apr. 2017 | 17 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Hafiz Chaudhry Ali als Direktor am 28. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Amy Christina Mckellar als Direktor am 17. Okt. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKELLAR, Craig | Geschäftsführer | Blackmoor Road Ebblake Industrial Estate BH31 6BE Verwood Profinish Print Services Dorset England | England | British | 216816310001 | |||||||||
| AHMED, Mukhtar | Sekretär | 27 Black Moor Road Ebblake Industrial Estate BH31 6BE Verwood Unit 7 & 8 England | 210455550001 | |||||||||||
| SHENTON, Kimberley Ann | Sekretär | Commercial Road BH14 0HU Poole 31/33 Dorset United Kingdom | British | 175662680001 | ||||||||||
| WROE, Lesley Ann | Sekretär | 7 Warmwell Close Canford Heath BH17 8AW Poole Dorset | British | 85275420001 | ||||||||||
| APEX COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 46a Syon Lane TW7 5NQ Isleworth Middlesex | 900004340001 | |||||||||||
| ML SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Commercial Road BH14 0HU Poole 31-33 Dorset |
| 105242480002 | ||||||||||
| AKBAR, Mansoor | Geschäftsführer | Rutland Avenue HP12 3JG High Wycombe 184 England | England | British | 105734540001 | |||||||||
| ALI, Hafiz Chaudhry | Geschäftsführer | 27 Black Moor Road Ebblake Industrial Estate BH31 6BE Verwood Unit 7 & 8 England | England | Pakistani | 226868610001 | |||||||||
| CRAIG, Mckellar | Geschäftsführer | Bath Road Taplow SL6 0PR Maidenhead 751 England | England | British | 214769420001 | |||||||||
| MCKELLAR, Amy Christina | Geschäftsführer | Blackmoor Road Ebblake Industrial Estate BH31 6BE Verwood Profinish Print Services Dorset England | England | British | 210455030001 | |||||||||
| MCKELLAR, Amy Christina | Geschäftsführer | 27 Black Moor Road Ebblake Industrial Estate BH31 6BE Verwood Units 7-8 Dorset England | England | British | 210455030001 | |||||||||
| SHENTON, Ian | Geschäftsführer | Commercial Road BH14 0HU Poole 31/33 Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 85275370003 | |||||||||
| WROE, Keith Michael | Geschäftsführer | Commercial Road BH14 0HU Poole 31/33 Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 85675980001 | |||||||||
| WROE, Keith Michael | Geschäftsführer | 7 Warmwell Close Canford Heath BH17 8AW Poole Dorset | United Kingdom | British | 85675980001 | |||||||||
| YASIN, Mohammed | Geschäftsführer | Rutland Avenue HP12 3JG High Wycombe 184 Buckinghamshire England | England | British | 106284780001 | |||||||||
| APEX NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 46a Syon Lane TW7 5NQ Isleworth Middlesex | 900004330001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Miss Amy Christina Mckellar | 22. Juni 2016 | Bath Road Taplow SL6 0PR Maidenhead 751 England | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 24. Apr. 2017 Geliefert am 28. Apr. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All assets of company by way of a first fixed and floating charge.. Note: the company is precluded without the consent in writing of factor 21 (north) limited from creating any further charge upon all or any of the book and other debts due to it ranking either in priority to or pari passu with this charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chatels mortgage | Erstellt am 18. Nov. 2004 Geliefert am 19. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The equipment being 2004 sakurui SC102A ii, serial number: RT134904, equipment: 1990 trumax turbo combi, serial number: 0432590026, equipment: heidelberg cylindor, serial number: 26834 the proceeds of all policies of insurance now or in the future taken out by the company in respect of the equipment and the benefit of all options and rights evolving upon the company under any such policy of insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Jan. 2004 Geliefert am 08. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 17. Nov. 2003 Geliefert am 18. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant and machinery being heidelberg sbd cylinder serial number 32136 or any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 07. Apr. 2003 Geliefert am 12. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 27. Jan. 2003 Geliefert am 01. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PROFINISH PRINT SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0