TRAVELZEST PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRAVELZEST PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 04520457
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRAVELZEST PLC?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TRAVELZEST PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRAVELZEST PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VFB GROUP PLC28. Aug. 200228. Aug. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVELZEST PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TRAVELZEST PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVELZEST PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Sept. 2014

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Sept. 2014

    10 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Mai 2014

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    34 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    11 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Farm Cottage Heath House Wedmore Somerset BS28 4UG am 12. Nov. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2013 ohne Mitgliederliste

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 31. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 2,902,722.2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Carroll als Geschäftsführer am 30. Juli 2013

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Thomas John Molyneux als Geschäftsführer am 19. Apr. 2013

    2 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2012

    72 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 29/01/2012
    RES13
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor, Delta Place, 27 Bath Road Cheltenham Gloucestershire GL53 7th am 13. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2012 ohne Mitgliederliste

    8 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Carroll am 06. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2011

    73 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11

    Beendigung der Bestellung von James Dominic Brooke als Geschäftsführer am 11. Apr. 2012

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Jack Fraser als Geschäftsführer am 26. März 2012

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Jack Fraser als Geschäftsführer am 26. März 2012

    2 SeitenTM01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Ernennung von Adrian Cobbold als Direktor am 09. Jan. 2012

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRAVELZEST PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Sekretär
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    British771320001
    COBBOLD, Adrian
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    CanadaCanada Uk166995390001
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    EnglandBritish771320001
    JENKINS, Nigel John
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    EnglandBritish24257330003
    DAVIES, Dunstana Adeshola
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    Sekretär
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    British55368820001
    SCRIP SECRETARIES LIMITED
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    Sekretär
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    74920110001
    BROOKE, James Dominic
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    EnglandBritish156641930001
    BRUCE MITFORD, Michael John
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    Geschäftsführer
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    United KingdomBritish84293460004
    CARROLL, Jonathan
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    Geschäftsführer
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    CanadaCanadian119934340001
    CHRYSANTHOU, Chrysanthos Theoclis
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    Geschäftsführer
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    British90764380001
    FRASER, John Jack
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    Geschäftsführer
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    CanadaCanadian139187050001
    MCKINLAY, Colin Grant
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    British112065020002
    MOLYNEUX, Mark Thomas John
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    Geschäftsführer
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    British58976290002
    MOTTERSHEAD, Christopher Alan Leigh
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish144988920001
    ROBB, Nishma
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    British117867060001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74298510001
    THOMSON, Peter
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    Geschäftsführer
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    British84232180001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    Hat TRAVELZEST PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 20. März 2012
    Geliefert am 28. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account name barclays bank PLC re travelzest PLC mandatory prepayment account sort code: 20-65-82 account number: 13548465. account name barclays bank PLC re travelzest PLC bms cash cover sort code: 20-65-82 account number: 13483762.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal assignment of keyman policy
    Erstellt am 22. Dez. 2009
    Geliefert am 30. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The keyman policy being the policy of life and critical illness assurance with policy number L0193123333 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security and note pledge agreement
    Erstellt am 19. Juni 2008
    Geliefert am 03. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors or any one or more of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The instruments and securities including 7,000,000 ordinary securities in travelzest canco limited, all substitutions and replacements of and increases additions, and accessionss to the property, all proceeds derived from the property, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 03. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 2008
    Geliefert am 26. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any finance party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge over shares
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge over shares
    Erstellt am 08. Aug. 2007
    Geliefert am 11. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge over shares
    Erstellt am 19. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The shares and deivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal assignment of key man policies
    Erstellt am 19. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy no 012259278-5 legal & general mr c mckinley sum assured £1,000,000, policy no 012258792-6 legal & general mr cal mottershead sum assured £1,000,000 and policy no 012259283-5 legal & general mrs nishma robb sum assured £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge over shares
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 28. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    100 ordinary shares of £1 each in wow house limited together with any stocks, shares and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable share charge
    Erstellt am 08. Nov. 2006
    Geliefert am 14. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge over shares
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all the companys rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security pledge agreement
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    100 common shares and all rights and claims in such securities all substitutions and replacements of increases and additions to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat TRAVELZEST PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Nov. 2013Beginn der Verwaltung
    12. Sept. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0