TRAVELZEST PLC
Überblick
| Unternehmensname | TRAVELZEST PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 04520457 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRAVELZEST PLC?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TRAVELZEST PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRAVELZEST PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VFB GROUP PLC | 28. Aug. 2002 | 28. Aug. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVELZEST PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TRAVELZEST PLC?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVELZEST PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Sept. 2014 | 10 Seiten | 2.24B | ||||||||||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Sept. 2014 | 10 Seiten | 2.35B | ||||||||||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Mai 2014 | 10 Seiten | 2.24B | ||||||||||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 34 Seiten | 2.17B | ||||||||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 11 Seiten | 2.16B | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Farm Cottage Heath House Wedmore Somerset BS28 4UG am 12. Nov. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2013 ohne Mitgliederliste | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Carroll als Geschäftsführer am 30. Juli 2013 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Thomas John Molyneux als Geschäftsführer am 19. Apr. 2013 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2012 | 72 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor, Delta Place, 27 Bath Road Cheltenham Gloucestershire GL53 7th am 13. Nov. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2012 ohne Mitgliederliste | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jonathan Carroll am 06. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2011 | 73 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Dominic Brooke als Geschäftsführer am 11. Apr. 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Jack Fraser als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Jack Fraser als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Adrian Cobbold als Direktor am 09. Jan. 2012 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRAVELZEST PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, Richard Gordon | Sekretär | Farm Cottage Heath House BS28 4UG Wedmore Somerset | British | 771320001 | ||||||
| COBBOLD, Adrian | Geschäftsführer | Matheson Boulevard East Mississauga 2350 Ontario Canada | Canada | Canada Uk | 166995390001 | |||||
| HALL, Richard Gordon | Geschäftsführer | Farm Cottage Heath House BS28 4UG Wedmore Somerset | England | British | 771320001 | |||||
| JENKINS, Nigel John | Geschäftsführer | Old Surrey Hall RH19 3PR East Grinstead The Coach House West Sussex | England | British | 24257330003 | |||||
| DAVIES, Dunstana Adeshola | Sekretär | 20 Northcote Road CR0 2HT Croydon Surrey | British | 55368820001 | ||||||
| SCRIP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 5th Floor 17 Hanover Square W1S 1HU London | 74920110001 | |||||||
| BROOKE, James Dominic | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 Uk | England | British | 156641930001 | |||||
| BRUCE MITFORD, Michael John | Geschäftsführer | Welsh Newton Common NP25 5RR Monmouth Newton House Gwent | United Kingdom | British | 84293460004 | |||||
| CARROLL, Jonathan | Geschäftsführer | 18 Yorkville Ave, Unit 3002 Toronto Ontario M4w 3y8 Canada | Canada | Canadian | 119934340001 | |||||
| CHRYSANTHOU, Chrysanthos Theoclis | Geschäftsführer | 69 Firs Park Avenue Winchmore Hill N21 2PR London | British | 90764380001 | ||||||
| FRASER, John Jack | Geschäftsführer | Graywood Drive Etobicoke 14 Ontario M9a 1p6 Canada | Canada | Canadian | 139187050001 | |||||
| MCKINLAY, Colin Grant | Geschäftsführer | Crossways Farm Nettleden Road HP1 3DQ Nettleden Hertfordshire | British | 112065020002 | ||||||
| MOLYNEUX, Mark Thomas John | Geschäftsführer | Rockfield Park Rockfield NP5 3QB Monmouth Gwent | British | 58976290002 | ||||||
| MOTTERSHEAD, Christopher Alan Leigh | Geschäftsführer | Theccans Ringshall HP4 1LU Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 144988920001 | |||||
| ROBB, Nishma | Geschäftsführer | Flat 13 40 Eastcote Road HA5 1DH Pinner Middlesex | British | 117867060001 | ||||||
| SMITH, David | Geschäftsführer | Firley 17 Highlands Road Sear Green HP5 2XL Beaconfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 74298510001 | |||||
| THOMSON, Peter | Geschäftsführer | 23 Fenners Lawn Gresham Road CB1 2EH Cambridge | British | 84232180001 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 |
Hat TRAVELZEST PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 20. März 2012 Geliefert am 28. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account name barclays bank PLC re travelzest PLC mandatory prepayment account sort code: 20-65-82 account number: 13548465. account name barclays bank PLC re travelzest PLC bms cash cover sort code: 20-65-82 account number: 13483762. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment of keyman policy | Erstellt am 22. Dez. 2009 Geliefert am 30. Dez. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The keyman policy being the policy of life and critical illness assurance with policy number L0193123333 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security and note pledge agreement | Erstellt am 19. Juni 2008 Geliefert am 03. Juli 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured creditors or any one or more of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The instruments and securities including 7,000,000 ordinary securities in travelzest canco limited, all substitutions and replacements of and increases additions, and accessionss to the property, all proceeds derived from the property, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juni 2008 Geliefert am 26. Juni 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies or any of them to any finance party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge over shares | Erstellt am 14. Sept. 2007 Geliefert am 18. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge over shares | Erstellt am 08. Aug. 2007 Geliefert am 11. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge over shares | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 21. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The shares and deivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment of key man policies | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 21. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy no 012259278-5 legal & general mr c mckinley sum assured £1,000,000, policy no 012258792-6 legal & general mr cal mottershead sum assured £1,000,000 and policy no 012259283-5 legal & general mrs nishma robb sum assured £1,000,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge over shares | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 28. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 100 ordinary shares of £1 each in wow house limited together with any stocks, shares and other securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable share charge | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 14. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge over shares | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all the companys rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security pledge agreement | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 100 common shares and all rights and claims in such securities all substitutions and replacements of increases and additions to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRAVELZEST PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0