SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04524306 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Jan. 2021 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Westgate Brewery Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1QT, United Kingdom zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 28. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Apr. 2019
| 4 Seiten | SH02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Apr. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Dyson Davis als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Smothers als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Mai 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 6 | 13 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 7 | 11 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 8 | 13 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Sekretär | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | British | 92581040002 | ||||||
| SMOTHERS, Richard | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| BACKHOUSE, Nicholas Paul | Sekretär | 30 Cathcart Road SW10 9NN London | British | 64723790002 | ||||||
| LUCK, Richard Nigel | Sekretär | Herschel Grange Warfield RG42 6AT Bracknell 4 Berkshire | British | 61070930001 | ||||||
| NEWHALL NOMINEES LIMITED | Sekretär | 115 Colmore Row B3 3AL Birmingham | 18182520002 | |||||||
| ANAND, Rooney | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | England | British | 77808680003 | |||||
| BACKHOUSE, Nicholas Paul | Geschäftsführer | 30 Cathcart Road SW10 9NN London | United Kingdom | British | 64723790002 | |||||
| BRIDGE, Timothy John Walter | Geschäftsführer | Priory Farm Shudy Camps CB1 6RE Cambridge | United Kingdom | British | 35576730001 | |||||
| BRIGGS, Hugh Alexander | Geschäftsführer | Brick Kiln Cottage Farm Berkhamsted Common HP4 1PU Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 215065730001 | |||||
| BROWN, David Anthony | Geschäftsführer | Westgate Brewery Bury St Edmunds IP33 1QT Suffolk | England | British | 163139060001 | |||||
| BROWN, David Anthony | Geschäftsführer | Westgate Brewery Bury St Edmunds IP33 1QT Suffolk | England | British | 163139060001 | |||||
| BULL, Ian Alan | Geschäftsführer | Westgate Brewery Bury St Edmunds IP33 1QT Suffolk | England | British | 210299090001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| FEARN, Matthew Robin Cyprian | Geschäftsführer | Westgate Brewery Bury St Edmunds IP33 1QT Suffolk | United Kingdom | British | 109155280002 | |||||
| FENNEY, Paul Francis | Geschäftsführer | Porch House Church Street Buckden PE19 5SX St Neots Cambridgeshire | United Kingdom | British | 97980790001 | |||||
| FORRESTER, Karen Martha | Geschäftsführer | Flat 4 16 Harley Road Primrose Hill NW3 3BN London | England | British | 77261830001 | |||||
| KING, Christopher | Geschäftsführer | 6 Jocelyn Road TW9 2TH Richmond Surrey | British | 77423330001 | ||||||
| LIVINGSTONE, Ian Malcolm | Geschäftsführer | 80h Eaton Square SW1W 9AP London | British | 75831270003 | ||||||
| MORSE, Gary John | Geschäftsführer | 44 The Banks NN6 7QQ Long Buckby Northamptonshire | United Kingdom | British | 95950750001 | |||||
| PARKER, Raymond | Geschäftsführer | Wellfield House 82 High Street, Clayton West HD8 9NS Huddersfield West Yorkshire | England | British | 86304880001 | |||||
| PAYNE, Ian Timothy | Geschäftsführer | Rumbolds Spring Lane SG9 9QH Cottered Hertfordshire | England | British | 78974110003 | |||||
| SHALLOW, Michael St John | Geschäftsführer | Felsham Hall Felsham IP30 0QN Bury St Edmunds Suffolk | England | British | 31387250002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greene King Retailing Limited | 06. Apr. 2016 | Westgate Street IP33 1QT Bury St. Edmunds Westgate Brewery England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental deed of charge | Erstellt am 30. Juni 2008 Geliefert am 08. Juli 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the properties as specified on the schedule to the form 395 and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery, book and other debts. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental borrower deed of charge | Erstellt am 08. Mai 2006 Geliefert am 19. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the borrower security trustee or any other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the properties as specified on the schedule to the form 395 and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 07. März 2005 Geliefert am 22. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1550 abbott redhill f/h SY641089,5350 abingdon arms wantage f/h ON245493,5220 acall estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixture,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property,the ancillary property rights, all rights,title,benefit and interest,to and under the relevant documents and the insurance policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed supplemental to the trust deed dated 29 july 1991 | Erstellt am 06. Aug. 2004 Geliefert am 13. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £86,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 27 may 1997 | Erstellt am 06. Aug. 2004 Geliefert am 13. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £25,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 31. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Okt. 2002 Geliefert am 21. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Blackbirds flitwick high street MK45 1DX t/n BD218853, raby arms hart village hartlepool TS27 3AJ t/n CE157761, tredegar arms newport 4 caerphilly road bassaleg NP1 9LH t/n CYM19458, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental debenture | Erstellt am 06. Sept. 2002 Erworben am 07. Okt. 2002 Geliefert am 14. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Only parts of those assets which are subject to the supplemental debenture and the debenture were acquired by the company; see form 400 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0