JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04526228 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Marble Arch House 66 Seymour Street W1H 5BX London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Hammerson Company Secretarial Limited am 16. Jan. 2023 | 1 Seiten | CH04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kings Place 90 York Way London N1 9GE zum Marble Arch House 66 Seymour Street London W1H 5BX am 16. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Dominic Page als Direktor am 15. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Abigail Dunning als Geschäftsführer am 15. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Miss Abigail Dunning als Direktor am 11. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Warren Stuart Austin als Geschäftsführer am 11. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr. Paul Justin Denby als Direktor am 11. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Cochrane als Geschäftsführer am 19. Mai 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Thomas James Cochrane als Direktor am 07. Aug. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew John Berger-North als Geschäftsführer am 07. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMERSON COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 66 Seymour Street W1H 5BX London Marble Arch House England |
| 163656260001 | ||||||||||
| DENBY, Paul Justin | Geschäftsführer | 66 Seymour Street W1H 5BX London Marble Arch House England | England | British | 167898970002 | |||||||||
| PAGE, Dominic Martin Etienne | Geschäftsführer | 66 Seymour Street W1H 5BX London Marble Arch House England | United Kingdom | British | 293002100001 | |||||||||
| SHAW, Richard Geoffrey | Geschäftsführer | 66 Seymour Street W1H 5BX London Marble Arch House England | United Kingdom | British | 164073580003 | |||||||||
| DESAI, Falguni Rameshchandra | Sekretär | Apartment 108 20 Palace Street SW1E 5BA London | British | 77755390004 | ||||||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 83864780001 | |||||||||||
| APPLEYARD, Andrew Charles | Geschäftsführer | 55 Eton Rise Eton College Road NW5 2DQ London | United Kingdom | British | 124838360001 | |||||||||
| AUSTIN, Warren Stuart | Geschäftsführer | 90 York Way N1 9GE London Kings Place United Kingdom | United Kingdom | British | 135050800001 | |||||||||
| BERGER-NORTH, Andrew John | Geschäftsführer | 90 York Way N1 9GE London Kings Place United Kingdom | England | British | 134630050001 | |||||||||
| BLACK, Russell Norman | Geschäftsführer | Meadow Way Boxmoor HP3 0AT Hemel Hempstead 9 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 97983900003 | |||||||||
| CLARK, Philip John | Geschäftsführer | 26 Bourne Avenue Southgate N14 6PD London | United Kingdom | British | 101932350001 | |||||||||
| COCHRANE, Thomas | Geschäftsführer | 90 York Way N1 9GE London Kings Place | United Kingdom | British | 273384660001 | |||||||||
| CORAL, Lynda Sharon | Geschäftsführer | Westacre 1a Sandy Lodge Road WD3 1LP Moor Park Hertfordshire | British | 34029880004 | ||||||||||
| DUNNING, Abigail Jane | Geschäftsführer | 90 York Way N1 9GE London Kings Place | United Kingdom | British | 293555050001 | |||||||||
| FORD, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 43 Hans Place SW1X 0JZ London | England | British | 52710005 | |||||||||
| HAMILL, Luke | Geschäftsführer | Crystal Palace Road East Dulwich SE22 9JQ London 227 | United Kingdom | British | 114139360002 | |||||||||
| JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | 76584200002 | |||||||||
| JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | 76584200002 | |||||||||
| LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr | Geschäftsführer | High House Ranworth Road Hemblington NR13 4PJ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 62939740001 | |||||||||
| LEWIS PRATT, Andrew | Geschäftsführer | 61 Blandford Street W1U 7HR London | British | 60050050008 | ||||||||||
| MANSLEY, Nicholas John Fermor | Geschäftsführer | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | 73817060002 | |||||||||
| NELL, Philip John Payton | Geschäftsführer | Bury Lodge Bury Lane Elmdon CB11 4NQ Saffron Walden Essex | England | British | 105566370001 | |||||||||
| NIKOLIC, Krysto Archibald Milan | Geschäftsführer | 47-51 Gillingham Street SW1V 1HS London Flat 2 Sovereign Court | Uk | British | 138589710001 | |||||||||
| PULLEN, Xavier | Geschäftsführer | 65 Studdridge Street SW6 3SL London | England | British | 78912170008 | |||||||||
| ROBSON, Jonathan | Geschäftsführer | 151 Gladstone Road Wimbledon SW19 1QS London | United Kingdom | British | 109313040002 | |||||||||
| STAVELEY, Charles Andrew Rover | Geschäftsführer | Riverdale Gardens TW1 2BZ Twickenham 17 United Kingdom | England | British | 133771640001 | |||||||||
| SUNNUCKS, William D'Urban | Geschäftsführer | East Gores Farm Salmons Lane CO6 1RZ Coggeshall Essex | England | British | 32866350001 | |||||||||
| THODAY, Corin Leonard | Geschäftsführer | Norwich Road NR21 8AU Fakenham 21 Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | 138095630001 | |||||||||
| WESTBROOK, Will Gowanloch | Geschäftsführer | St. Marys Grove W4 3LL London 3 Uk | Uk | British | 170744070001 | |||||||||
| WOMACK, Ian Bryan | Geschäftsführer | 6 Southwood Lawn Road Highgate N6 5SF London | England | British | 33902000006 | |||||||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Geschäftsführer | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London | 94701880001 | |||||||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 900026650001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Junction (General Partner) Limited | 06. Apr. 2016 | 90 York Way N1 9GE London Kings Place United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Erstellt am 01. Feb. 2010 Geliefert am 16. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor's to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 139 renfrew road paisley t/n REN84846. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 01. Feb. 2010 Geliefert am 16. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor's to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 131 to 137 renfrew road paisley t/n REN107888. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 29. Juni 2005 Geliefert am 12. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the finance parties acting by its general partner on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole right, title and interest in and to the rents and all other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 30 june 2005 and | Erstellt am 22. Juni 2005 Geliefert am 18. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming the food units at great western retail park, glasgow t/no GLA118891 together with, the whole buildings and erections, the heritable fittings and fixtures, the whole rights parts privilages and pertinents, the chargor's whole right, title and interest present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 24. Dez. 2004 Geliefert am 31. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects known as and forming kittybrewster retail park in theecimal or one-thousandth parts of an acre (9.881 acres) or thereby lying on or towards the north or north-west of bedford road kittybrewster. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 23 december 2004 | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 12. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks and as security trustee for the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Kittybrewster retail park in the city and county of aberdeen t/no: ABN76942. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 09. Juli 2004 Geliefert am 14. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Lease between chartwell land investments limited and carpetright PLC dated 29 january and 26 february 1996; lease between the royal bank of scotland trust company (jersey) limited and rbsi trust company limited, a share & sons limited and scs upholstery PLC dated 2 and 22 may; lease among chartwell land investments limited and allied carpets properties limited and allied carpets group limited dated 24 january and 26 february 1996 for details of further leases charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH july 2004 and | Erstellt am 28. Juni 2004 Geliefert am 20. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming great western retail park glasgow t/n GLA109583. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 28. Feb. 2003 Geliefert am 18. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from junction nominee 1 limited and junction nominee 2 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Whole right title and interest in and to the rents and all other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of legal charge | Erstellt am 26. Feb. 2003 Geliefert am 28. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property k/a blackpole retail park and electricity substation at blackpole road, worcester, t/n HW31552 and HW91910, all plant, machinery and fixtures and fittings, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the proceeds of any insurance, the goodwill and the charged assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of legal charge | Erstellt am 26. Feb. 2003 Geliefert am 28. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property k/a imperial park, land at the south side of hartcliffe way, bristol t/n BL62799, all plant, machinery and fixtures and fittings, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the proceeds of any insurance, the goodwill and the charged assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 7 march 2003 and | Erstellt am 14. Feb. 2003 Geliefert am 14. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 139 renfrew road, paisley t/n REN5373 and abbotsinch industrial estate, washington road, paisley t/n REN47336. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 03. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a reading retail park being land to the south west of oxford road, reading t/no. BK268828 ot any part of it. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 03. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties of any kind under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of legal charge | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 03. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The victory trading estate burrfields road copnor portsmouth PO3 5LP freehold property title number HP166152. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of leagal charge | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 03. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ocean retail park being land to the north of burrfields road copnor portsmouth freehold title number HP352024. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0