JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJUNCTION NOMINEE 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04526228
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Marble Arch House
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Änderung der Details des Sekretärs für Hammerson Company Secretarial Limited am 16. Jan. 2023

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kings Place 90 York Way London N1 9GE zum Marble Arch House 66 Seymour Street London W1H 5BX am 16. Jan. 2023

    1 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Dominic Page als Direktor am 15. Feb. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Abigail Dunning als Geschäftsführer am 15. Feb. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Miss Abigail Dunning als Direktor am 11. Nov. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Warren Stuart Austin als Geschäftsführer am 11. Nov. 2021

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr. Paul Justin Denby als Direktor am 11. Nov. 2021

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Cochrane als Geschäftsführer am 19. Mai 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Thomas James Cochrane als Direktor am 07. Aug. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew John Berger-North als Geschäftsführer am 07. Aug. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAMMERSON COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Sekretär
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer7784823
    163656260001
    DENBY, Paul Justin
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Geschäftsführer
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    EnglandBritish167898970002
    PAGE, Dominic Martin Etienne
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Geschäftsführer
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    United KingdomBritish293002100001
    SHAW, Richard Geoffrey
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Geschäftsführer
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    United KingdomBritish164073580003
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Sekretär
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    OLSWANG COSEC LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Sekretär
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    83864780001
    APPLEYARD, Andrew Charles
    55 Eton Rise
    Eton College Road
    NW5 2DQ London
    Geschäftsführer
    55 Eton Rise
    Eton College Road
    NW5 2DQ London
    United KingdomBritish124838360001
    AUSTIN, Warren Stuart
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish135050800001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    EnglandBritish134630050001
    BLACK, Russell Norman
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97983900003
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Geschäftsführer
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COCHRANE, Thomas
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Geschäftsführer
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United KingdomBritish273384660001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    British34029880004
    DUNNING, Abigail Jane
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Geschäftsführer
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United KingdomBritish293555050001
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Geschäftsführer
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritish52710005
    HAMILL, Luke
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    Geschäftsführer
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    United KingdomBritish114139360002
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Geschäftsführer
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Geschäftsführer
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LEWIS PRATT, Andrew
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    Geschäftsführer
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    British60050050008
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Geschäftsführer
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish105566370001
    NIKOLIC, Krysto Archibald Milan
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    Geschäftsführer
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    UkBritish138589710001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Geschäftsführer
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritish78912170008
    ROBSON, Jonathan
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    Geschäftsführer
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    United KingdomBritish109313040002
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish133771640001
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Geschäftsführer
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritish32866350001
    THODAY, Corin Leonard
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish138095630001
    WESTBROOK, Will Gowanloch
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    Geschäftsführer
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    UkBritish170744070001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Geschäftsführer
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritish33902000006
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Seventh Floor
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Geschäftsführer
    Seventh Floor
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    94701880001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    900026650001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4278233
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat JUNCTION NOMINEE 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security
    Erstellt am 01. Feb. 2010
    Geliefert am 16. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor's to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 139 renfrew road paisley t/n REN84846.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security
    Erstellt am 01. Feb. 2010
    Geliefert am 16. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor's to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 131 to 137 renfrew road paisley t/n REN107888.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 12. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties acting by its general partner on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title and interest in and to the rents and all other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agents for the Banks and Security Trustee for the Financeparties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30 june 2005 and
    Erstellt am 22. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects forming the food units at great western retail park, glasgow t/no GLA118891 together with, the whole buildings and erections, the heritable fittings and fixtures, the whole rights parts privilages and pertinents, the chargor's whole right, title and interest present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agents for the Banks and Security Trustee for the Financeparties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 24. Dez. 2004
    Geliefert am 31. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as and forming kittybrewster retail park in theecimal or one-thousandth parts of an acre (9.881 acres) or thereby lying on or towards the north or north-west of bedford road kittybrewster. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 23 december 2004
    Erstellt am 20. Dez. 2004
    Geliefert am 12. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks and as security trustee for the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Kittybrewster retail park in the city and county of aberdeen t/no: ABN76942.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents
    Erstellt am 09. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Lease between chartwell land investments limited and carpetright PLC dated 29 january and 26 february 1996; lease between the royal bank of scotland trust company (jersey) limited and rbsi trust company limited, a share & sons limited and scs upholstery PLC dated 2 and 22 may; lease among chartwell land investments limited and allied carpets properties limited and allied carpets group limited dated 24 january and 26 february 1996 for details of further leases charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH july 2004 and
    Erstellt am 28. Juni 2004
    Geliefert am 20. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects forming great western retail park glasgow t/n GLA109583.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 18. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from junction nominee 1 limited and junction nominee 2 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Whole right title and interest in and to the rents and all other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/a blackpole retail park and electricity substation at blackpole road, worcester, t/n HW31552 and HW91910, all plant, machinery and fixtures and fittings, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the proceeds of any insurance, the goodwill and the charged assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/a imperial park, land at the south side of hartcliffe way, bristol t/n BL62799, all plant, machinery and fixtures and fittings, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the proceeds of any insurance, the goodwill and the charged assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 7 march 2003 and
    Erstellt am 14. Feb. 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    139 renfrew road, paisley t/n REN5373 and abbotsinch industrial estate, washington road, paisley t/n REN47336.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 03. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a reading retail park being land to the south west of oxford road, reading t/no. BK268828 ot any part of it. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 03. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties of any kind under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 03. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The victory trading estate burrfields road copnor portsmouth PO3 5LP freehold property title number HP166152. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of leagal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 03. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ocean retail park being land to the north of burrfields road copnor portsmouth freehold title number HP352024. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0