SPEEDY LIFTING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPEEDY LIFTING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04529136 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPEEDY LIFTING LIMITED?
- Vermietung und Leasing von anderen Maschinen, Geräten und Sachanlagen n.a. (77390) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Chase House 16 The Parks Newton Le Willows WA12 0JQ Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 1817 LIMITED | 09. Sept. 2002 | 09. Sept. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Sept. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 23. Sept. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Sept. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2025 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2024 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Paul Adrian Rayner als Direktor am 09. Dez. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von James Richard Bunn als Geschäftsführer am 09. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Daniel John Evans als Direktor am 01. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Russell Down als Geschäftsführer am 30. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Daniel John Evans als Geschäftsführer am 18. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von James Richard Bunn als Direktor am 18. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Daniel John Evans als Direktor am 31. Juli 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Christopher Morgan als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 8 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Russell Down am 31. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Russell Down am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Neil John | Sekretär | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | 238485880001 | |||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| EVANS, Daniel John | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 272760890001 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| BLAIR, James Edward | Sekretär | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | 168697390001 | |||||||
| KONCAREVIC, Suzana | Sekretär | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | British | 139800190001 | ||||||
| MCGRATH, Michael Andrew | Sekretär | Abbey Barn Macclesfield Road SK11 9AH Chelford Cheshire | British | 82005890002 | ||||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Sekretär | 7a The Crescent CW8 1QS Hartford Cheshire | British | 58219210002 | ||||||
| RAWNSLEY, Patrick James | Sekretär | Grove Avenue LS29 9PL Ilkley The Ghyll West Yorkshire | Other | 108571170002 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| ATHERTON, Simon Geoffrey Montague | Geschäftsführer | 2 Blind Lane Breaston DE72 3DW Derby Derbyshire | British | 53515260002 | ||||||
| ATKIN, Tracey Maria | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 191937420001 | |||||
| BENNETT, Antony | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 131483020001 | |||||
| BOTTOMS, John Cuthbertson | Geschäftsführer | 3 Clarkes Lane Aston On Trent DE72 2AB Derby Derbyshire | British | 112998420001 | ||||||
| BROWN, John Ernest | Geschäftsführer | 10 Stonegate Fold Heath Charnock PR6 9DX Chorley Lancashire | England | British | 11806560001 | |||||
| BUNN, James Richard | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 274171570001 | |||||
| CORCORAN, Steven James | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 39358260003 | |||||
| DOWN, Russell | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 253603400001 | |||||
| EVANS, Daniel John | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 272760890001 | |||||
| EVLEY, Darren | Geschäftsführer | Trent Lane DE72 2BT Weston-On-Trent 21 Derby | British | 130893320001 | ||||||
| KRIGE, Lynette Gillian | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 90566820002 | |||||
| LONGMIRE, Anthony | Geschäftsführer | 189 Pepper Lane Standish WN6 0PN Wigan Lancashire | England | British | 58065120001 | |||||
| MARTYR, Brian | Geschäftsführer | 3 Eynesford Close Stanground PE2 8UY Peterborough Cambridgeshire | British | 100819010001 | ||||||
| MCGRATH, Michael Andrew | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 82005890002 | |||||
| MONTGOMERY, David | Geschäftsführer | 46 Downton Rise Rumney CF3 3BH Cardiff | British | 92852100001 | ||||||
| MORGAN, Thomas Christopher | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 168031500001 | |||||
| NAYLOR, Colin Michael | Geschäftsführer | Harrowgate Cottage Harrowgate Lane TS19 8HE Cleveland | British | 116690800001 | ||||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Geschäftsführer | 7a The Crescent CW8 1QS Hartford Cheshire | United Kingdom | British | 58219210002 | |||||
| READ, Justin Richard | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 67023680001 | |||||
| ROGERSON, Mark | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 168247970001 | |||||
| SIMPSON, Andrew Christopher | Geschäftsführer | 51 Broomfield Road SK4 4LZ Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 112776340001 | |||||
| SWIFT, Carrie | Geschäftsführer | 19 Thornescroft Gardens Branston DE14 3GL Burton Upon Trent Staffordshire | British | 116690760001 | ||||||
| VERITIERO, Claudio | Geschäftsführer | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | England | British | 120476150001 | |||||
| WHITWORTH, Mark | Geschäftsführer | 2 Old Beechfield Gardens WN6 0UR Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 120679580001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPEEDY LIFTING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedy Hire Plc | 06. Apr. 2016 | 16 The Parks WA12 0JQ Newton-Le-Willows Chase House Merseyside United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0