M B BUILDING SERVICES LIMITED

M B BUILDING SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameM B BUILDING SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04532958
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    • Sonstige Bauinstallationen (43290) / Bauwesen

    Wo befindet sich M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mountview Court
    1148 High Road
    N20 0RA Whetstone
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TATE BUILDING SERVICES LIMITED12. Sept. 200212. Sept. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    22 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juni 2019

    17 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juni 2018

    19 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    17 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Juni 2017

    13 SeitenLIQ03

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    9 Seiten1.4

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Forge House Summerleys Road Princes Risborough Buckinghamshire HP27 9DT England zum Mountview Court 1148 High Road Whetstone London N20 0RA am 06. Juli 2016

    1 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Juni 2016

    LRESEX

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Nov. 2015

    14 Seiten1.3

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed tate building services LIMITED\certificate issued on 06/01/16
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name06. Jan. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 18. Dez. 2015

    RES15

    Beendigung der Bestellung von Michael George Jewell als Geschäftsführer am 05. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mark Browne als Direktor am 05. Nov. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    4 SeitenAA

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Nov. 2014

    8 Seiten1.3

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    4 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 045329580004

    38 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 045329580005

    38 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Cawley Place 15 Cawley Road Chichester West Sussex PO19 1UZ* am 21. März 2014

    1 SeitenAD01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von M B BUILDING SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWNE, Mark
    1148 High Road
    N20 0RA Whetstone
    Mountview Court
    London
    Geschäftsführer
    1148 High Road
    N20 0RA Whetstone
    Mountview Court
    London
    EnglandBritish202800720001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    M7 4AS Salford
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    M7 4AS Salford
    900014920001
    SHORE SECRETARIES LIMITED
    14 Church Road
    East Wittering
    PO20 8PS Chichester
    Demar House
    West Sussex
    Sekretär
    14 Church Road
    East Wittering
    PO20 8PS Chichester
    Demar House
    West Sussex
    63752250002
    TFP BUSINESS SERVICES LIMITED
    Kenilworth Hambledon Road
    Denmead
    PO7 6NU Waterlooville
    Hampshire
    Sekretär
    Kenilworth Hambledon Road
    Denmead
    PO7 6NU Waterlooville
    Hampshire
    107878850001
    JEWELL, Michael George
    Forge House
    Summerleys Road
    HP27 9DT Princes Risborough
    3
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Forge House
    Summerleys Road
    HP27 9DT Princes Risborough
    3
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish77007030001
    SIMMS, Nigel Christopher
    7 Eastern Parade
    PO16 0SD Fareham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    7 Eastern Parade
    PO16 0SD Fareham
    Hampshire
    British84490660001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Hat M B BUILDING SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2014
    Geliefert am 03. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. as security for the payment of the secured monies, the company with full title guarantee gave the following mortgages and charges in regency factors PLC’s favour, namely:. (A) a legal mortgage on the properties (as defined) (if any) specified in schedule 2 to the debenture;. (B) a legal mortgage on all properties (as defined) (if any) (other than any properties (as defined below) specified in schedule 2 to the debenture) now owned by the company or in which the company has an interest;. (C) a fixed charge on all of the following assets, whether now or in future belonging to the company:. I. The freehold and leasehold properties (as defined) of the company not effectively mortgaged under this clause including such as may hereafter be acquired;. Ii. All fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery in, on or attached to the property subject to the legal mortgages under this clause and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. Iii. Any other freehold and leasehold property which the company shall own together with all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery in, on or attached to such property and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. Iv. All their goodwill, unpaid and/or uncalled capital;. V. all their intellectual property (as defined). Together with the other assets charged in the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Regency Factors PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2014
    Geliefert am 03. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. as security for the payment of the secured monies, the company with full title guarantee gave the following mortgages and charges in regency factors PLC’s favour, namely:. (A) a legal mortgage on the properties (as defined) (if any) specified in schedule 2 to the debenture;. (B) a legal mortgage on all properties (as defined) (if any) (other than any properties (as defined below) specified in schedule 2 to the debenture) now owned by the company or in which the company has an interest;. (C) a fixed charge on all of the following assets, whether now or in future belonging to the company:. I. The freehold and leasehold properties (as defined) of the company not effectively mortgaged under this clause including such as may hereafter be acquired;. Ii. All fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery in, on or attached to the property subject to the legal mortgages under this clause and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. Iii. Any other freehold and leasehold property which the company shall own together with all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery in, on or attached to such property and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. Iv. All their goodwill, unpaid and/or uncalled capital;. V. all their intellectual property (as defined). Together with the other assets charged in the debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Regency Factors PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    All assets debenture
    Erstellt am 26. Mai 2011
    Geliefert am 01. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 10. Juni 2009
    Geliefert am 11. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 103A forest road laytonstone london t/no:EGL116983 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2009
    Geliefert am 23. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)

    Hat M B BUILDING SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Nov. 2013Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    16. Dez. 2016Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fiona Grant
    Wilson Field Limited The Manor House
    260 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    Praktiker
    Wilson Field Limited The Manor House
    260 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    Robert Neil Dymond
    The Manor House 260 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Praktiker
    The Manor House 260 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    2
    DatumTyp
    24. Juni 2016Beginn der Liquidation
    05. Dez. 2020Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andreas Arakapiotis
    Mountview Court, 1148 High Road
    Whetstone
    N20 0RA London
    Praktiker
    Mountview Court, 1148 High Road
    Whetstone
    N20 0RA London
    Elizabeth Arakapiotis
    Kallis & Company
    Mountview Court
    N20 0RA 1148 High Road
    Whetstone London
    Praktiker
    Kallis & Company
    Mountview Court
    N20 0RA 1148 High Road
    Whetstone London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0