NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED

NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNDNA REGIONAL CENTRES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04534962
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    ARMSTRONG WATSON
    Central House 47 St Pauls Street
    LS1 2TE Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PARTDEGREE LIMITED13. Sept. 200213. Sept. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. März 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. März 2010

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    8 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 30. März 2009

    LRESEX

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2007

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TANUKU, Purnima Murthy
    17 Bradyll Court
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8AS Blackburn
    Lancashire
    Sekretär
    17 Bradyll Court
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8AS Blackburn
    Lancashire
    British57282270001
    CARR, Sarah
    The Homestead
    Ballam Road
    FY8 4NL Lytham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Homestead
    Ballam Road
    FY8 4NL Lytham
    Lancashire
    United KingdomBritish87270620001
    MURPHY, Lynne Rosemary
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    British71399540001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CHURCHLEY, Peter Knight
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    EnglandBritish77173520001
    MURPHY, Lynne Rosemary
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71399540001
    THOMPSON, Michael Anthony Norcott
    The Manor House
    Church Lane
    WD25 78B Aderhem
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Church Lane
    WD25 78B Aderhem
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8598480003
    WALKER, Karen Evelyn
    81 School Lane
    WF15 8AW Hartshead
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    81 School Lane
    WF15 8AW Hartshead
    West Yorkshire
    United KingdomBritish53035820002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 14. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being f/h land being land on the east side of rift house primary school, masefield road, hartelpool t/no CE171732; l/h land being land on the north east side of trent road, grantham t/no LL240153; l/h land being land and buildings at norwood green school, thorncliffe road, heston t/no AGL130993, for details of further properties charged please refer to form 395, first fixed equitable charge the insurances and all future easements and other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The New Opportunities Fund
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 20. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property at hodge hill girls school bromford lane hodge hill birmingham. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Nov. 2004
    Geliefert am 16. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the ground floor and part of the first floor of library buildings, victoria square, widnes, halton. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Juni 2004
    Geliefert am 18. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land at norwood green school, heston,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2004
    Geliefert am 02. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings at trent road grantham lincolnshire. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over agreement for lease
    Erstellt am 21. Jan. 2004
    Geliefert am 23. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee all of the rights title and interest in and to the agreement dated 5 september 2003 for the development of land and buildings at norwood green school, heston, hounslow and the proposed lease of such property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 21. Okt. 2003
    Geliefert am 05. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2003
    Geliefert am 14. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at macefield road hartlepool (being the former rift house community site). By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Juli 2003
    Geliefert am 29. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Hat NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. März 2009Beginn der Liquidation
    09. Apr. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Christian Kienlen
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds
    Praktiker
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0