LS REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLS REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04552005
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LS REALISATIONS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich LS REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LS REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LAIDLAW SOLUTIONS LIMITED24. Sept. 200324. Sept. 2003
    EDGER 310 LIMITED02. Okt. 200202. Okt. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LS REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für LS REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Dez. 2016

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 14. Dez. 2016

    19 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juni 2016

    37 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    4 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    49 Seiten2.17B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed laidlaw solutions LIMITED\certificate issued on 15/01/16
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. Jan. 2016

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Leaderflush Shapland Milnhay Road Langley Mill Nottingham NG16 4AZ zum 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 08. Jan. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 146,664
    SH01

    Ernennung von Mr Edward John Riley als Direktor am 21. Okt. 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Edward Riley als Sekretär am 30. Sept. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Peter Thomond O'brien als Geschäftsführer am 21. Okt. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Sime als Sekretär am 30. Sept. 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Alan Sime als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    21 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Ian Colin Hopkinson als Geschäftsführer am 25. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2014 bis 31. Dez. 2014

    1 SeitenAA01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2015 bis 31. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr Alan Sime als Sekretär am 28. Nov. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Alison Ruth Hoskin als Sekretär am 28. Nov. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 146,664
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    23 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LS REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RILEY, Edward
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Sekretär
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    202660280001
    JEFFERIES, John
    2 Long Hey Way
    Caldy
    CH48 1LZ Wirral
    Croft Lodge
    Merseyside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Long Hey Way
    Caldy
    CH48 1LZ Wirral
    Croft Lodge
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish132190060001
    RILEY, Edward John
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Geschäftsführer
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    EnglandBritish60757430002
    BEECH, David Shaun
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    Sekretär
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    153551240001
    CLARK, Trevor John
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    Sekretär
    Unit 23 Strawberry Lane
    Willenhall
    WV13 3RS West Midlands
    174197310001
    CUTHBERTSON, John William
    Hillcote 7 Linton Avenue
    LS22 6SQ Wetherby
    West Yorkshire
    Sekretär
    Hillcote 7 Linton Avenue
    LS22 6SQ Wetherby
    West Yorkshire
    British96511610001
    HOSKIN, Alison Ruth
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    Sekretär
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    181521530001
    JEFFERIES, John
    6 Heatherleigh
    Caldy
    CH48 1QZ Wirral
    Merseyside
    Sekretär
    6 Heatherleigh
    Caldy
    CH48 1QZ Wirral
    Merseyside
    British83647600001
    REARDON, Timothy Philip
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    Sekretär
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    British91906070001
    SIME, Alan
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    Sekretär
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    193062960001
    WALKER, Alastair James
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    Sekretär
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    British123331600001
    CRESCENT HILL LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024050001
    CLEMENT, Craig Darren
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    Geschäftsführer
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    England
    EnglandBritish102403040003
    CROSS, Stevan Paul
    6 Marling Close
    WA6 6AY Frodsham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Marling Close
    WA6 6AY Frodsham
    Cheshire
    British93218310001
    HOPKINSON, Ian Colin
    Bryn Celyn
    Berth Ddu, Rhosesmor
    CH7 6PS Mold
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Bryn Celyn
    Berth Ddu, Rhosesmor
    CH7 6PS Mold
    Clwyd
    WalesBritish76627690001
    O'BRIEN, Peter Thomond
    16 St Johns Road
    WA16 0DP Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 St Johns Road
    WA16 0DP Knutsford
    Cheshire
    EnglandEnglish,Irish54240700002
    REARDON, Timothy Philip
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Mayfair Drive
    Fazeley
    B78 3TG Tamworth
    Staffordshire
    British91906070001
    SIME, Alan
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    Geschäftsführer
    Milnhay Road
    Langley Mill
    NG16 4AZ Nottingham
    Leaderflush Shapland
    EnglandBritish51759580002
    WALKER, Alastair James
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    Geschäftsführer
    23 Barlow Way
    CW11 1PB Sandbach
    Cheshire
    United KingdomBritish123331600001
    ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Dumfries House
    Dumfries Place
    CF1 4YF Cardiff
    900024040001

    Hat LS REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Mai 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Accession deed to a debenture dated 17 september 2012 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ashwani Malhan
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Mai 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Accession deed to a debenture dated 1 august 2011 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rutland Partners LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    All asset debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2012
    Geliefert am 22. Dez. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 1 and 2 north muirton industrial estate arran road perth scotland t/no pth 20021 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2009
    Geliefert am 20. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 25. Juni 2009
    Geliefert am 27. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 24. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit sum of £5,625.
    Berechtigte Personen
    • Ian Joseph Warfield, David Andrew Jones, Wayne Ernest Abuzaid and Union Pension Trusteeslimited
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/11/03 and
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Units 1 & 2 north muirton estate arran road perth PK1 3DE.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 22. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the west side of neachells lane, wednesfield t/nos WM518802, WM419610 and WM522122.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 22. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit a dakota avenue, salford, greater manchester t/no GM474433.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 10. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ir Security & Safety Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LS REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Dez. 2015Beginn der Verwaltung
    14. Dez. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Michael Hawes
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0