LS REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LS REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04552005 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LS REALISATIONS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LS REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Brindley Place B1 2HZ Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LS REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LAIDLAW SOLUTIONS LIMITED | 24. Sept. 2003 | 24. Sept. 2003 |
| EDGER 310 LIMITED | 02. Okt. 2002 | 02. Okt. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LS REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LS REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Dez. 2016 | 19 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 14. Dez. 2016 | 19 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juni 2016 | 37 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 4 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 49 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed laidlaw solutions LIMITED\certificate issued on 15/01/16 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Leaderflush Shapland Milnhay Road Langley Mill Nottingham NG16 4AZ zum 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 08. Jan. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Edward John Riley als Direktor am 21. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Edward Riley als Sekretär am 30. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Thomond O'brien als Geschäftsführer am 21. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Sime als Sekretär am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Sime als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Colin Hopkinson als Geschäftsführer am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2014 bis 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2015 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Sime als Sekretär am 28. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Ruth Hoskin als Sekretär am 28. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LS REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RILEY, Edward | Sekretär | Brindley Place B1 2HZ Birmingham 4 | 202660280001 | |||||||
| JEFFERIES, John | Geschäftsführer | 2 Long Hey Way Caldy CH48 1LZ Wirral Croft Lodge Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 132190060001 | |||||
| RILEY, Edward John | Geschäftsführer | Brindley Place B1 2HZ Birmingham 4 | England | British | 60757430002 | |||||
| BEECH, David Shaun | Sekretär | Unit 23 Strawberry Lane Willenhall WV13 3RS West Midlands | 153551240001 | |||||||
| CLARK, Trevor John | Sekretär | Unit 23 Strawberry Lane Willenhall WV13 3RS West Midlands | 174197310001 | |||||||
| CUTHBERTSON, John William | Sekretär | Hillcote 7 Linton Avenue LS22 6SQ Wetherby West Yorkshire | British | 96511610001 | ||||||
| HOSKIN, Alison Ruth | Sekretär | Milnhay Road Langley Mill NG16 4AZ Nottingham Leaderflush Shapland England | 181521530001 | |||||||
| JEFFERIES, John | Sekretär | 6 Heatherleigh Caldy CH48 1QZ Wirral Merseyside | British | 83647600001 | ||||||
| REARDON, Timothy Philip | Sekretär | 1 Mayfair Drive Fazeley B78 3TG Tamworth Staffordshire | British | 91906070001 | ||||||
| SIME, Alan | Sekretär | Milnhay Road Langley Mill NG16 4AZ Nottingham Leaderflush Shapland | 193062960001 | |||||||
| WALKER, Alastair James | Sekretär | 23 Barlow Way CW11 1PB Sandbach Cheshire | British | 123331600001 | ||||||
| CRESCENT HILL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Dumfries House Dumfries Place CF1 4YF Cardiff | 900024050001 | |||||||
| CLEMENT, Craig Darren | Geschäftsführer | Milnhay Road Langley Mill NG16 4AZ Nottingham Leaderflush Shapland England | England | British | 102403040003 | |||||
| CROSS, Stevan Paul | Geschäftsführer | 6 Marling Close WA6 6AY Frodsham Cheshire | British | 93218310001 | ||||||
| HOPKINSON, Ian Colin | Geschäftsführer | Bryn Celyn Berth Ddu, Rhosesmor CH7 6PS Mold Clwyd | Wales | British | 76627690001 | |||||
| O'BRIEN, Peter Thomond | Geschäftsführer | 16 St Johns Road WA16 0DP Knutsford Cheshire | England | English,Irish | 54240700002 | |||||
| REARDON, Timothy Philip | Geschäftsführer | 1 Mayfair Drive Fazeley B78 3TG Tamworth Staffordshire | British | 91906070001 | ||||||
| SIME, Alan | Geschäftsführer | Milnhay Road Langley Mill NG16 4AZ Nottingham Leaderflush Shapland | England | British | 51759580002 | |||||
| WALKER, Alastair James | Geschäftsführer | 23 Barlow Way CW11 1PB Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | 123331600001 | |||||
| ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Dumfries House Dumfries Place CF1 4YF Cardiff | 900024040001 |
Hat LS REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 23. Mai 2013 Geliefert am 07. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Accession deed to a debenture dated 17 september 2012 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 23. Mai 2013 Geliefert am 07. Juni 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Accession deed to a debenture dated 1 august 2011 creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of laidlaw solutions limited, as more particularly described in clause 5 of the accession deed.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All asset debenture | Erstellt am 20. Dez. 2012 Geliefert am 22. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1 and 2 north muirton industrial estate arran road perth scotland t/no pth 20021 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Nov. 2009 Geliefert am 20. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 25. Juni 2009 Geliefert am 27. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 24. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit sum of £5,625. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/11/03 and | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 04. Dez. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Units 1 & 2 north muirton estate arran road perth PK1 3DE. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 22. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the west side of neachells lane, wednesfield t/nos WM518802, WM419610 and WM522122. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 22. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit a dakota avenue, salford, greater manchester t/no GM474433. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 10. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 06. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LS REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0